ROWAN LEASING LIMITED

ROWAN LEASING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROWAN LEASING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02028239
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROWAN LEASING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ROWAN LEASING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Arjohuntleigh House Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ROWAN LEASING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARJO MECANAIDS LEASING LIMITED14 apr 198814 apr 1988
    MECANAIDS (EXPORT SALES) LIMITED13 giu 198613 giu 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROWAN LEASING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ROWAN LEASING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ROWAN LEASING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2014

    Stato del capitale al 01 lug 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Christoffer David Erik Franzen come amministratore in data 11 giu 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Mark Bloom come amministratore in data 11 giu 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Khizer Ismail Ibrahim come amministratore in data 11 giu 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Nomina di Mr Khizer Ismail Ibrahim come amministratore in data 30 giu 2013

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alpesh Khakhar come amministratore in data 30 giu 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    Nomina di Mr Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt come amministratore in data 01 dic 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Leif Erik Martensson come amministratore in data 01 dic 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Matthew William Stork come amministratore in data 27 mar 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Leif Erik Martensson come amministratore in data 27 mar 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Alpesh Khakhar come amministratore in data 31 gen 2012

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 310-312 Dallow Road Luton Bedfordshire LU1 1TD United Kingdom in data 09 feb 2012

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Matthew William Stork come amministratore in data 31 gen 2012

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di ROWAN LEASING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLOOM, Richard Mark
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    155157660001
    BLOOM, Richard Mark
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish118671260002
    FRANZEN, Christoffer David Erik
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandSwedish188458510001
    VAN DEN BELT, Robert Nicolaas Wilko
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    SwedenDutch175232950001
    LOCK, Robert Francis
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    Segretario
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    British61939850001
    TELLING, Deborah Joanne
    Roslyn 11 Kent Avenue
    HR9 5AH Ross On Wye
    Herefordshire
    Segretario
    Roslyn 11 Kent Avenue
    HR9 5AH Ross On Wye
    Herefordshire
    British86321030002
    WOZENCROFT, Andrew John
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    Segretario
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    British16102100001
    FRICK, Bertil Anders
    Ribersborgsvagen 38
    FOREIGN Malmo 21753
    Sweden
    Amministratore
    Ribersborgsvagen 38
    FOREIGN Malmo 21753
    Sweden
    Swedish16109750001
    IBRAHIM, Khizer Ismail
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish180060740001
    JONES, Ian
    Dallow Road
    LU1 1TD Luton
    310-312
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Dallow Road
    LU1 1TD Luton
    310-312
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish243954370001
    KHAKHAR, Alpesh
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish166582980001
    LOCK, Robert Francis
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    Amministratore
    Oak House Priors Frome
    Upper Dormington
    HR1 4EF Hereford
    United KingdomBritish61939850001
    MARTENSSON, Leif Erik
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    SwedenSwedish153479400001
    RICHARDSON, Bruce Nigel
    9 Aggs Close
    Gotherington
    GL52 9HD Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    9 Aggs Close
    Gotherington
    GL52 9HD Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish86365790001
    STORK, Matthew William
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Houghton Hall Business Park
    Houghton Regis
    LU5 5XF Dunstable
    Arjohuntleigh House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160838320001
    VACHER, Peter Edward
    11 Walker Gardens
    Hedge End
    SO30 2RH Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    11 Walker Gardens
    Hedge End
    SO30 2RH Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish117473420001
    WOZENCROFT, Andrew John
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pleasant Stile
    Littledean
    GL14 3NX Cinderford
    Temple Cottage
    Gloucestershire
    British16102100001

    ROWAN LEASING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Sub-lease assignment
    Creato il 16 mar 1998
    Consegnato il 03 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 23RD december 1996 in respect of one boeing 737-400 aircraft serial no.24070 Reg. No. G-bnnl
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to an amended and restated aircraft lease agreement dated 16TH march 1998 between the company and GB airways limited in respect of the aircraft including the right to recieve all payments required to be paid by GB airways in connection with the sub-lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • International Lease Finance Corportion
    Transazioni
    • 03 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-lease agreement
    Creato il 16 mar 1998
    Consegnato il 03 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 23RD december 1996 in respect of boeing 737-400 aicraft serial number 24069 reg. No g-bnnk
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to an amended and restated aircraft lease agreement (the "sub-lease") dated 16.03.98 between the company and GB airways limited in respect of the aircraft including the right to receive all payments required to be paid by GB airways under or in connection with the sub-lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • International Lease Finance Corporation
    Transazioni
    • 03 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-lease assignment
    Creato il 23 dic 1996
    Consegnato il 13 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or in connection with a lease of even date
    Brevi particolari
    All rights title and interest in under and to a sub-lease dated 30TH november 1994 in respect of the aircraft being one boeing 737-400 aircraft manufacturer's serial no: 24069 and UK re mark g-bnnk including without limitation the right to receive all payments required to be paid by gba under or in connection with the sub-lease all sums received or recoverable by the company in respect of the insurances described in the sub-lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • International Lease Finance Corporation
    Transazioni
    • 13 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-lease assignment
    Creato il 23 dic 1996
    Consegnato il 13 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or in connection with a lease of even date
    Brevi particolari
    All rights title and interest in under and to a sub-lease dated 30TH november 1994 in respect of the aircraft being one boeing 737-400 aircraft manufacturer's serial no: 24070 and UK reg mark g-bnnl including without limitation the right to receive all payments required to the paid by gba under or in connection with the sub-lease all sums received or recoverable by the company in respect of the insurances described in the sub-lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • International Lease Finance Corporation
    Transazioni
    • 13 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0