MCC LEASING (NO. 6) LIMITED

MCC LEASING (NO. 6) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMCC LEASING (NO. 6) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02030523
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagine4.71

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 1 Churchill Place London E14 5HP a Barlcays Group Archives Dallimore Road Manchester Manchester M23 9JA

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Churchill Plaza Churchill Way Basingstoke Hampshire RG21 7GP a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 20 nov 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 nov 2015

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 ago 2015

    Stato del capitale al 13 ago 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Mohammed Akram come amministratore in data 13 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2015

    Stato del capitale al 19 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    23 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    6 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 gen 2014

    Stato del capitale al 06 gen 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Gavin John Simpson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Duncan Rowberry come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2013

    25 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 giu 2012

    25 pagineAA

    Nomina di Mohammed Akram come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Geoffrey Ridout come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    27 pagineAA

    Cessazione della carica di Darren Hare come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di MCC LEASING (NO. 6) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARCOSEC LIMITED
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Segretario
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    49004930002
    LEATHER, Jonathan Terence
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish69140360004
    SIMPSON, Gavin John
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish149333050001
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Segretario
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    AKRAM, Mohammed
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish169142800001
    BOOBYER, Christopher Leslie Richard
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British92233050001
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Amministratore
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Amministratore
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    HARE, Darren Mark
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    United KingdomBritish147858890001
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MCMILLAN, Richard John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British68601920003
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Amministratore
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    RIDOUT, Thomas Geoffrey
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    Amministratore
    Churchill Place
    E14 5HP London
    1
    England
    EnglandBritish155056490001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    EnglandBritish49237880004
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    Amministratore
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    British71785600001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    MCC LEASING (NO. 6) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Sub lease security agreement
    Creato il 30 dic 1992
    Consegnato il 14 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing the performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease dated 24/11/92 and from the company under the terms of the head lease dated 24/11/92
    Brevi particolari
    All the grantor's right title and interest as lessee in the head lease and as secured party in the head security agreement (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Triborough Bridge and Tunnel Authority
    Transazioni
    • 14 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Secondary lease security assignment
    Creato il 30 dic 1992
    Consegnato il 13 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from i/s mardron and/or tarben J.B.olesen to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30/12/92
    Brevi particolari
    All the right title and interest in and to the assigned payments and sums paid or payable in respect thereof (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First priority statutory mortgage
    Creato il 30 giu 1987
    Consegnato il 13 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or svenska handelsbanten and/or barclays bank PLC acting as agent for itself pursuant to a guarantee facility agreement dated 30/7/87
    Brevi particolari
    32/64TH shares in the M.V. "st. Nicholas" registered at the port of london under official no 703472 and in her boats and appurtenances.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC and/or Svenska Handelsbanken and/or Barclays Bank PLC Actingas Agent
    Transazioni
    • 13 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 24 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of covenants
    Creato il 30 giu 1987
    Consegnato il 13 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent for itself and svenska handelsbanken pursuant to a guarantees facility agreement dated 30 june 1987 and this deed.
    Brevi particolari
    All the right title & interest in the vessel M.V. "st nicholas" registered at the part of london official no. 703472 and all boats machinery etc. (see doc M86/14 jul/cf for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 24 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    MCC LEASING (NO. 6) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 nov 2015Inizio della liquidazione
    07 lug 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0