UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED

UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02033103
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED?

    • Attività delle società di finanziamento ipotecario (64922) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road
    Whitefield
    M45 7TA Greater Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROWN BROTHERS ACCEPTANCES LIMITED01 lug 198601 lug 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    19 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 dic 2022

    19 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 dic 2021

    20 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Adamson House C/O Burton Varley 10 Adamson House Towers Business Park Didsbury Manchester M20 2YY United Kingdom a Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road Whitefield Greater Manchester M45 7TA in data 16 set 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 dic 2020

    LRESSP

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mag 2020

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 95 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 97 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 96 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 98 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 80 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 54 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 55 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 62 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 75 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 76 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 77 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 81 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 82 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 93 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 59 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 94 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRANSTON, Jonathan David Selby
    Elms Square Bury New Road
    Whitefield
    M45 7TA Greater Manchester
    Leonard Curtis House
    Amministratore
    Elms Square Bury New Road
    Whitefield
    M45 7TA Greater Manchester
    Leonard Curtis House
    EnglandBritishCompany Director13138380004
    HIORNS, Trevor John
    12 Ashwell Road
    Bygrave
    SG7 5DT Baldock
    Hertfordshire
    Segretario
    12 Ashwell Road
    Bygrave
    SG7 5DT Baldock
    Hertfordshire
    British19855280001
    MERRIMAN, Jayne Elizabeth
    Mayfield
    65 Taunton Road
    OL7 9DR Ashton Under Lyne
    Segretario
    Mayfield
    65 Taunton Road
    OL7 9DR Ashton Under Lyne
    BritishPersonal Assistant35668070002
    BROWN, Dennis Hugh
    23b Grove End Road
    NW8 9BP London
    Amministratore
    23b Grove End Road
    NW8 9BP London
    BritishCompany Director12189730002
    BURTON, Jeffrey Norman
    Jandra 66 Chapel Lane
    Halebarns
    WA15 0AQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Jandra 66 Chapel Lane
    Halebarns
    WA15 0AQ Altrincham
    Cheshire
    BritishChartered Accountant43896400001
    JOHNSON, Sharon
    Shenton Park Avenue
    M33 4NZ Sale
    No 8
    Cheshire
    Amministratore
    Shenton Park Avenue
    M33 4NZ Sale
    No 8
    Cheshire
    BritishManager139510190001
    MONTLAKE, Carl Lawrence
    14 Lloyd Street
    M2 5ND Manchester
    Amministratore
    14 Lloyd Street
    M2 5ND Manchester
    BritishMortgage Broker69149120002
    REFSON, Lionel Natan
    2 Stitch Lane
    SK4 2LS Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    2 Stitch Lane
    SK4 2LS Stockport
    Cheshire
    BritishCompany Director58983200003

    Chi sono le persone con controllo significativo di UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Jonathan David Selby Cranston
    Elms Square Bury New Road
    Whitefield
    M45 7TA Greater Manchester
    Leonard Curtis House
    06 apr 2016
    Elms Square Bury New Road
    Whitefield
    M45 7TA Greater Manchester
    Leonard Curtis House
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Sub-charge
    Creato il 14 ago 2009
    Consegnato il 20 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charge of even date between richard michael dodsworth and universal acceptances limited relating to 56 green lane acomb york YO24 4PS.
    Persone aventi diritto
    • Finance and Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 20 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub charge
    Creato il 03 lug 2009
    Consegnato il 10 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £130,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A charge relating to the property k/a 9A milton street saltburn by the sea redcar and cleveland t/no. CE52287 and the principal monies secured by the charge see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Finance and Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 10 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub charge
    Creato il 16 mar 2009
    Consegnato il 27 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £41,250 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A charge dated 16TH march 2009 and made between darren leigh connolly (1) universal acceptances limited (2) and the principal monies secured by the charge see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Finance and Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 27 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 31 lug 2002
    Consegnato il 06 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £35,000.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    196 keyham rd,devonport,plymouth PL2 1RD; dn 18720.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 12 lug 2002
    Consegnato il 17 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of twenty five thousand pounds together with interest thereon at the agreed rate due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Legal charge between universal acceptances limited and ronald smith in respect of 15 st bedes avenue blackpool FY4 1AQ t/no: LA410281.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2002
    Consegnato il 03 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 16 gen 2002
    Consegnato il 25 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £35,000 toether with interest thereon at the agreed rate due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The legal charge dated 16TH january 2002 made between universal acceptances limited and wai kwong yung in respect of 52 fore street new quay cornwall t/n-CL126537.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 25 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 08 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £77,500.00 together with interest and costs thereon due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The freehold property known as kippax new mill, goodsshawfold road, rossendale, lancs BB4 8QN t/no: LA871334.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 08 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 04 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £70,000 due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    The legal charge of even date over the f/h property k/a 34 high street, downham market, PE38 9HH t/no NK243067.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 04 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 06 dic 2001
    Consegnato il 11 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000 together wih interest due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The legal charge dated 06/12/01 made between the company and sheila margaret devanney in respect of 29 st werburghs road chorlton-cum-hardy manchester M21 1TL t/n LA163057.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 11 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 05 ott 2001
    Consegnato il 09 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of thirty five thousand pounds together with interest due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 28A popin business centre south way wembley middlesex title number NGL674515.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 09 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 31 ago 2001
    Consegnato il 06 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The legal charge dated 31 august 2001 in respect of all that f/h property being land at the rear of 976 eastern avenue and lying to the south of eastern avenue, ilford, essex IG2 7JD t/n EGL289300.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 06 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 06 lug 2001
    Consegnato il 10 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The legal charge dated 6TH july 2001 in respewct of all that f/h property being unit 12 larkstore park lodge road spalehurst tonbridge kent TN12 0QY and the principal monies secured by the charge and all interest thereon due or to become due and the benefit of all securities.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 10 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 04 mag 2001
    Consegnato il 12 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,000.00 together with interest due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The legal charge dated 4TH may 2001 in respect of all that freehold property being the queen hotel, 195 lumb lane, bradford BD8 7SG and the principal monies secured by the charge and all interest thereon due or to become due and the benefit of all securities.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 12 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge of a registered charge
    Creato il 15 set 2000
    Consegnato il 19 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £42,000.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/Hold property known as foulsham garage station road foulsham east dereham norfolk; t/no NK196556. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub charge
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    A charge over 11 town street shepton mallett somerset dated 1ST october 1996 entered into by ronald ernest lionel gane.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub charge
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A charge over stubley mill garage stubley mill road littleborough lancashire dated 23 september 1996 entered into by christopher alan hill.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub charge
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A charge over 459 alexandra avenue rayners lane harrow dated 10 february 1998 entered into by david norman blewitt.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub charge
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A charge over 36 high street herne bay kent dated 31 may 1996 entered into by florina stella petrou and petros and petros paviou petrou.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub charge
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A charge over 18 priory road liverpool dated 18 august 1997 entered into by robert james guy.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub charge
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    A charge over 14 priory road liverpool dated 18 october 1997 entered into by robert james guy.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 27 giu 2000
    Consegnato il 13 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40,000 from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Property k/a 9,11 and 13 leeds road windhill shipley - WYX48978 and all principal monies secured and all interest thereon; the benefit of all securities thereof.
    Persone aventi diritto
    • Finance and Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 13 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 07 apr 2000
    Consegnato il 20 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £105,000.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    115A burlington rd,new malden; t/no sgl 478467 and all principal monies secured and all interest thereon; the benefit of all securities thereof.
    Persone aventi diritto
    • Finance and Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 20 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 17 nov 1999
    Consegnato il 18 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £40,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The charge dated 17TH may 1999 over the property k/a 20 worthing road rustington west sussex t/no: WSX123673.
    Persone aventi diritto
    • Finance & Credit Corporation Limited
    Transazioni
    • 18 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Sub-charge
    Creato il 02 mar 1999
    Consegnato il 09 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All or any monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 9 gresley close drayton fields daventree t/n-NN141844. F/h 10 gresley close drayton fields daventree t/n-NN142208. By way of first fixed charge all interest and other sums now owing or hereafter to become owing to it in respect of the mortgage with the payment to the lender of the indebtedness;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Arbuthnot Latham & Co Limited
    Transazioni
    • 09 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    UNIVERSAL ACCEPTANCES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 dic 2020Inizio della liquidazione
    17 ott 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steve Markey
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    Praticante
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    Martin Maloney
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Greater Manchester
    Praticante
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Greater Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0