THORNE POULTRY LIMITED

THORNE POULTRY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHORNE POULTRY LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02035669
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THORNE POULTRY LIMITED?

    • Produzione di prodotti a base di carne e di carne di pollame (10130) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova THORNE POULTRY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BDO LLP
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THORNE POULTRY LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2014
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2015
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per THORNE POULTRY LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al30 nov 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 dic 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THORNE POULTRY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per THORNE POULTRY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei soci

    3 pagineREST-MVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 31 mag 2016

    24 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    24 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 apr 2016

    20 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 5Th Floor 6 St. Andrew Street London England and Wales EC4A 3AE a C/O Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU in data 06 mag 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 apr 2015

    LRESSP

    Varie

    Section 519 companies act 2006
    1 pagineMISC

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 feb 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 feb 2015

    Stato del capitale al 16 feb 2015

    • Capitale: GBP 1,570,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 dic 2013

    Stato del capitale al 10 dic 2013

    • Capitale: GBP 1,570,000
    SH01

    Cessazione della carica di Peter Miller come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Leon Barry Abbitt come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Steven come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Louis Vernaus come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Maarten Kusters come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di THORNE POULTRY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    ABBITT, Leon Barry
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish153119640001
    ROXBURGH, Roy
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    British194640001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Segretario
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Segretario
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Segretario
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Amministratore
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    EnglandBritish105961550001
    FYFE, Archibald
    14 Cloverfield Place
    Bucksburn
    AB2 9RH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    14 Cloverfield Place
    Bucksburn
    AB2 9RH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British957330001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    KUSTERS, Maarten
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    BelgiumDutch167543410001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Amministratore
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    MILLER, Peter John
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    United KingdomBritish55542610002
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Amministratore
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SIMS, David John
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish52926050001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritish159788300001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Amministratore
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001

    THORNE POULTRY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second ranking security agreement (assignment of receivables)
    Creato il 02 ott 2012
    Consegnato il 15 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any subordinated secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns absolutely all of its rights in respect of the assigned receivables; and under each loan agreement that it is a party to.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 15 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    First ranking security agreement (assignment of receivables)
    Creato il 02 ott 2012
    Consegnato il 15 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any senior secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns absolutely all of its rights in respect of the assigned receivables; and under each loan agreement that it is a party to.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 15 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An intercreditor and security agreement
    Creato il 30 mag 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the dep. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mag 2007
    Consegnato il 08 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 dic 1998
    Consegnato il 23 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the guarantee including in particular all monies due by the trustees (as defined) under or in connection with any of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 14 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 14 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 ott 1995
    Consegnato il 04 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 ago 1992
    Consegnato il 21 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined) or the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the agreement or the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    Property in thorne,south yorkshire.t/nofor full details please see doc M24C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commercer Any of Them)Behalf of the Banks (As Defined) or the Banks (Ofor Itself and as Agent and Trustee for and On
    Transazioni
    • 21 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 ago 1992
    Consegnato il 21 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined) or the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the agreement or the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    Property in thorne,south yorkshire.t/no.for full details please see doc M23C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commercer Any of Them)Behalf of the Banks (As Defined) or the Banks (Ofor Itself and as Agent and Trustee for and On
    Transazioni
    • 21 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 ott 1990
    Consegnato il 24 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined) on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    Transazioni
    • 24 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 ott 1990
    Consegnato il 23 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent and trustee for and on behalf of the banks (as defined) on any account whatsoever under the terms of the agreement dated 5.10.90 and the security documents (as defined)
    Brevi particolari
    Property in thorne, south yorkshire. Title no. Syk 243859. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce
    Transazioni
    • 23 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 09 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental agreement to a chattel mortgage dtd 26.1.88
    Creato il 01 ago 1988
    Consegnato il 02 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a chattel mortgage dated 26.1.1988
    Brevi particolari
    1 x primary air chiller supplied by pennine indentity number 210-214 see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • British Coal Enterprise Limited
    Transazioni
    • 02 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 apr 1988
    Consegnato il 06 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to an agreement dated 11.1.88
    Brevi particolari
    178 franking machine cost-£1,062 supplier-pirney bowes (please see form 395 & schedule for full details).
    Persone aventi diritto
    • Dancaster Business Advice Centre.
    Transazioni
    • 06 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 26 gen 1988
    Consegnato il 28 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Two cochran wee chieftain bailers identity no's-160 & 161 one stork dry offal systems identity nos 012, 014, 020, 021/022, 026, 027, 028, 029, 030, 031 044, 053-057, 059-064, 074-077 (please see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • British Coal Enterprise Limited
    Transazioni
    • 28 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 set 1987
    Consegnato il 16 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 16 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THORNE POULTRY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 set 2016Data di scioglimento
    10 apr 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0