RUBY DCO TEN LIMITED

RUBY DCO TEN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRUBY DCO TEN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02040018
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RUBY DCO TEN LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova RUBY DCO TEN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Office 5, International House
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RUBY DCO TEN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MEDIMART LIMITED23 lug 198623 lug 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di RUBY DCO TEN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per RUBY DCO TEN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione di Admenta Holdings Limited come persona con controllo significativo il 31 ago 2023

    1 paginePSC07

    Notifica di Dunamis Mind Accelerator Limited come persona con controllo significativo il 31 ago 2023

    2 paginePSC02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Re: change of name / company shall be entitled to appoint a sole director / such director shall have the authority to exercise all powers and discretions of the directors confered by the articles 31/08/2023
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Thorsten Sprank come amministratore in data 31 ago 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Graham Wiseman come amministratore in data 31 ago 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dominik Muser come amministratore in data 31 ago 2023

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry CV2 2TX a Office 5, International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS in data 04 set 2023

    1 pagineAD01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed medimart LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name04 set 2023

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 31 ago 2023

    RES15

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 ago 2023

    • Capitale: GBP 630,001
    3 pagineSH01

    Stato del capitale al 29 ago 2023

    • Capitale: GBP 0.0001
    5 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share premium 29/08/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Nomina di Mr Dominik Muser come amministratore in data 06 lug 2023

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2023 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2022

    3 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Re-removal of restriction on authorised shares capital 07/09/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    33 pagineMA

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Cessazione della carica di Wendy Margaret Hall come amministratore in data 09 set 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nichola Louise Legg come segretario in data 09 set 2022

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di RUBY DCO TEN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPRANK, Thorsten
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Amministratore
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGerman203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Segretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LEGG, Nichola Louise
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    163214890001
    MURPHY, Francis Joseph
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    Segretario
    Oakmere Murieston Road
    WA15 9SU Hale
    Cheshire
    British32866430003
    ROCHE, Colleen Elisabeth
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British35456530001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Segretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    TWAROWSKI, Maria Elizabeth
    11 Spinners Chase
    Pudsey
    LS28 7BB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    11 Spinners Chase
    Pudsey
    LS28 7BB Leeds
    West Yorkshire
    British47378310001
    BARCLAY, Raymond Dunbar
    23 Cheviot Close
    Wash Common
    RG14 6SQ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    23 Cheviot Close
    Wash Common
    RG14 6SQ Newbury
    Berkshire
    British44192900001
    BEER, Thorsten
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman172030260001
    BURGAN, Lynne Frances
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish3311690001
    BURGAN, Philip John
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fulwood House Ling Lane
    Scarcroft
    LS14 3HY Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish2140090001
    ENGLAND, Philip Nicholas
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    Amministratore
    5 Park Avenue
    Peper Harrow Park
    GU8 6BA Godalming
    Surrey
    British43835770003
    HALL, Wendy Margaret
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    GermanyGerman238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Amministratore
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    KEEN, Christian
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    EnglandBritish54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Amministratore
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Amministratore
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    United KingdomGerman220582440001
    MAJOR, Michael Evelyn
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    Amministratore
    1 Frobisher Gardens
    GU1 2NT Guildford
    Surrey
    British31230890001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    MUSER, Dominik
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Amministratore
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    GermanyGerman295759150001
    PRIDMORE, Richard
    62 Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    62 Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DS Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish39535850001
    ROCHE, Colleen Elisabeth
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Whin View Woodacre Crescent
    Bardsey
    LS17 9DQ Leeds
    West Yorkshire
    British35456530001
    ROCHE, Patrick Joseph
    Penny Gate
    Swindon Lane Kirkby Overblow
    HG3 1HH Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Penny Gate
    Swindon Lane Kirkby Overblow
    HG3 1HH Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish126410600001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEWART, Brian
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    12 Fulwell Park Avenue
    TW2 5HQ Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish980530001
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British122881190001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    WISEMAN, Graham
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Amministratore
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandBritish299860960001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RUBY DCO TEN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dunamis Mind Accelerator Limited
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    31 ago 2023
    Cray Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    06 apr 2016
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneGreat Britain
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione244282
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    RUBY DCO TEN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 17 ott 1994
    Consegnato il 18 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-goldwick pharmacy glodwick health centre goldwick road, oldham including all guarantees and covenats now or in the future subsisting in respect of the property and the benefit of all insurance policies all moneys and proceeds paid or payable inrespect of the property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 18 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 lug 1994
    Consegnato il 30 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Brevi particolari
    F/H-459 great horton road bradford west yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 30 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 1994
    Consegnato il 18 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First charge on all stock shares bonds and securities of any kind whatsoever including all dividends interest or other distributions in respect of the same and all allotments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 18 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 giu 1994
    Consegnato il 18 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage
    Brevi particolari
    L/H-ground floor premises 280-282 lees road oldham lancs. Floating charge over all tha moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 18 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 1994
    Consegnato il 25 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-34 nostell place bessacarr doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 25 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 1994
    Consegnato il 25 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-the pharmacy sinclair house woodside view the crescent woodlands doncster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 25 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 1994
    Consegnato il 25 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-2 princess street woodlands doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 25 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 1994
    Consegnato il 25 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H- the pharmacy land and buildings on the east side of adwick road mexborough doncaster. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 25 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 1994
    Consegnato il 20 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-6 york bar york road doncaster. All moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 20 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 mag 1994
    Consegnato il 09 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-the pharmacy new street dinnington rotherham south yorkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 09 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 mar 1994
    Consegnato il 14 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-pharmacy at the new health centre cluntergate horbury wakefield west yorkshire t/n-WYK542628, WTK459121 and WYK55116 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 feb 1994
    Consegnato il 04 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan and/or this charge
    Brevi particolari
    First fixed charge on all stocks shares bonds and securities of any kind whatsoever including all dividends interest or other distributions paid or payable or made in respect of the same and allotments accreations offers rights benefits and advantages on all stocks shares rights money or property accruing or offered at any time by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 04 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 gen 1994
    Consegnato il 01 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan and/or this mortgage
    Brevi particolari
    L/H-48 cheapside barnsley south yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 01 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 24 gen 1994
    Consegnato il 26 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of a loan and/or under the terms of the debenture and security
    Brevi particolari
    L/H-3A far lane wadsley and land on the south side of wadsley lane and land on the N.E. of far lane sheffield t/n-SYK210526 and SYK313104. All moveable plant machinery equipment stock-in-trade implements utensils building materials and furniture by way of floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 26 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 dic 1993
    Consegnato il 18 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or aah pharmaceuticals limited to the chargee under the terms of a loan and/or this mortgage
    Brevi particolari
    L/H-the pharmacy minden centre st.johns garden the rock bury t/n-GM633326. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finanace Limited
    Transazioni
    • 18 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 dic 1993
    Consegnato il 18 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or aah pharmaceuticals limited to the chargee under the terms of a loan and/or this charge
    Brevi particolari
    L/H-unit 3 ribblesdale house market street bury t/n-GM512146. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finanace Limited
    Transazioni
    • 18 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 set 1993
    Consegnato il 14 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee
    Brevi particolari
    F/H-86 burgoyne road sheffield t/n-SYK113360. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 lug 1993
    Consegnato il 07 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal mortgage
    Brevi particolari
    L/H-13 halifax road dewsbury west yorkshire and stock-in-trade. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 07 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 giu 1993
    Consegnato il 07 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-50-52 high street idle bradford west yorkshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 07 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 apr 1993
    Consegnato il 06 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-property hereinafter described and the proceeds of sale thereof together with a at any time placed upon or used in or about the property and an assignment of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the property or any part or parts thereof together with the full benefit of all licences including any registrations viz: 21 and 21A chapeltown pudsey leeds west yorkshire t/n-WYK24687. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 mar 1993
    Consegnato il 08 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For full details see form 395 and contd sheets attached). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 08 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 feb 1993
    Consegnato il 04 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 04 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 set 1992
    Consegnato il 07 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H-26 main street garforth leeds west yorshire (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 07 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 giu 1992
    Consegnato il 05 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 05 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 apr 1992
    Consegnato il 22 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (For full details of property see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Statim Finance Limited
    Transazioni
    • 22 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0