STAGECOACH WEST LIMITED

STAGECOACH WEST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTAGECOACH WEST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02041677
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STAGECOACH WEST LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova STAGECOACH WEST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Daw Bank
    Stockport
    SK3 0DU Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STAGECOACH WEST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WESTERN TRAVEL LIMITED20 ott 198620 ott 1986
    EXPELOAK LIMITED29 lug 198629 lug 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di STAGECOACH WEST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per STAGECOACH WEST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mag 2013

    Stato del capitale al 07 mag 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Leslie Brian Warneford come amministratore in data 26 apr 2013

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 04 mar 2013

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Ian Roy Manning come amministratore in data 21 feb 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 apr 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 apr 2011

    14 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 apr 2010

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Roy Manning il 11 mag 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 10 ott 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 30 apr 2009

    13 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Leslie Brian Warneford il 01 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Colin Brown il 15 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 07 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di STAGECOACH WEST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Segretario
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    British70283550001
    HEMMING, Christopher Thomas
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Bankura Stoke Road
    Bishops Cleeve
    GL52 7RT Cheltenham
    Gloucestershire
    British17902220001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Segretario
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    British45931770001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    CARTER, Alex Paul
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    British41601830001
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Amministratore
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    British70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Amministratore
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    DAVISON, Jeremy Robert
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    Amministratore
    34 Trendlewood Park
    BS16 1TE Bristol
    British65096740001
    DYER, Andrew William
    10 Saxholm Way
    SO16 7GU Southampton
    Amministratore
    10 Saxholm Way
    SO16 7GU Southampton
    British62948690001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritish70283550001
    GLOAG, Ann Heron
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish141120003
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Amministratore
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    HILDITCH, Christopher Graham
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    British10417870001
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Amministratore
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritish2268190002
    HIRON, William
    10 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    10 Lock Close
    CV37 6GF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15390480001
    IRVING, Charles, Sir
    The Grange
    GL50 2JH Cheltenham
    Glos
    Amministratore
    The Grange
    GL50 2JH Cheltenham
    Glos
    British31938710001
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    LYON, Inglis
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    British72280120001
    MANNING, Ian Roy
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish90558800001
    RHYS-DAVIES, Mark Iorwedd
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    10 Evesham Road
    GL52 2AB Cheltenham
    Gloucestershire
    British5652350001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Amministratore
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish73518280001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Amministratore
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    United KingdomBritish45931770001
    STOCKLEY, Philip John
    Flat 31 Sirocco
    33 Channel Way
    SO14 3JE Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Flat 31 Sirocco
    33 Channel Way
    SO14 3JE Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish125533810001
    SUTTON, Martin
    44 Chandos Street
    Winchcombe
    GL54 5HX Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    44 Chandos Street
    Winchcombe
    GL54 5HX Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish54001710002
    THOMAS, Mark Richard
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Quarry House
    Upper Lynch Road France Lynch
    GL6 8LZ Stroud
    Gloucestershire
    British28914510001
    THOMAS, Norrie Russell
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    Amministratore
    Catherine Cottage Silver Street
    Chalford Hill
    GL6 8ES Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritish1447710001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004
    WHITE, Robert Neil Pratt
    18 Celandine Court
    Ty Canol
    NP44 6JU Cwmbran
    Gwent
    Amministratore
    18 Celandine Court
    Ty Canol
    NP44 6JU Cwmbran
    Gwent
    British20722660001
    WILLIAMS, Paul Raymond
    Lane House
    Quarry Place
    SY1 1JN Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    Lane House
    Quarry Place
    SY1 1JN Shrewsbury
    Salop
    United KingdomBritish8407960003

    STAGECOACH WEST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 12 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under the agreement and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without prejudice to the foregoing generality, all obligations to indemnify the chargee (the "secured liabilities") provided that the expression secured liabilites shall not include any relevant liabilities of the company
    Brevi particolari
    (1) as security for the payment of all secured liabilities, the chargor with full title guarantee charges in favour of the chargee for itself and as agent and security trustee aforesaid by way of floating charge all its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and as Agent and Security Trustee for and on Behalf of the Banks, the Issuing Bank and the Overdraft Bank
    Transazioni
    • 12 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot at gloucester road lansdown ind est cheltenham gloucs, all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot canal road cwmbach aberdare mid glamorgan all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot lake road brynmawr gwent all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot risca road crosskeys newport gwent all buildings and other structures, any goodwill, plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot somerset road st. David's road cwmbran gwent, all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery and other items, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 10 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot unit 20 merthyr tydfil ind est dowlais merthyr tydfil mid glamorgan, all buildings and other structures, any goodwill, all plant machinery etc, floating charge all unattached plant machinery chattels goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 02 feb 1996
    Consegnato il 17 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under any of the other finance documents and/or any deed or document supplemental thereto
    Brevi particolari
    By way of floating charge all its undertaking property assets and rights present and future.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and as Security Trustee for and on Behalf of the Banks the Issuing Bank and the Overdraft Bank
    Transazioni
    • 17 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1995
    Consegnato il 02 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot at eastcott road swindon wilts.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1995
    Consegnato il 02 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot at station approach leamington spa warwickshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1995
    Consegnato il 02 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot at new town road warwickshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1995
    Consegnato il 02 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot at railway terrace rugby warwickshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1995
    Consegnato il 02 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot at london road gloucester.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1995
    Consegnato il 02 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises at london road bowbridge stroud gloucestershire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 giu 1995
    Consegnato il 02 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus depot at canal street banbury oxfordshire.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 dic 1993
    Consegnato il 18 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as western travel limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 apr 1992
    Consegnato il 12 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please see doc M436C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ott 1986
    Consegnato il 10 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a share purchase agreement of even date.
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Bus Company
    Transazioni
    • 10 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 31 ott 1986
    Consegnato il 07 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Charge by way of specific equitable charge over all estates and/or interest of f/h & l/h property flowing charge over over taking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. (For full details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 07 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0