PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED

PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02043282
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHARTWELL LAND PROPERTIES LIMITED05 feb 199905 feb 1999
    CHARTWELL LAND OPERATIONAL PROPERTIES LIMITED23 ott 199823 ott 1998
    CHARTWELL DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED18 apr 198818 apr 1988
    WOOLWORTH PROPERTIES (MANAGEMENT) LIMITED03 dic 198603 dic 1986
    LEGIBUS 747 LIMITED04 ago 198604 ago 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Amanda Jane Jones come amministratore in data 08 nov 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 03 nov 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gavin Bergin come amministratore in data 03 nov 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2022

    15 pagineAA

    legacy

    251 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Cessazione della carica di Charles John Middleton come amministratore in data 31 mar 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Amanda Jane Jones come amministratore in data 18 mar 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bruce Michael James come amministratore in data 31 dic 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Gavin Bergin come amministratore in data 29 mar 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Nick Taunt come amministratore in data 05 ott 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Tom Robson come amministratore in data 11 set 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    3 pagineAA

    Nomina di Josephine Hayman come amministratore in data 31 gen 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Tom Robson come amministratore in data 31 gen 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione8992198
    187856670001
    HAYMAN, Josephine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish266797860001
    TAUNT, Nicholas Henry
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish275050860001
    CLIFTON, Sally Jane
    Braeside
    Old Micheldever Road
    SP11 7AF Longparish
    Hampshire
    Segretario
    Braeside
    Old Micheldever Road
    SP11 7AF Longparish
    Hampshire
    British77925190001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Segretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Segretario
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    LAWLEY, Anne Katharine
    25 Parkside
    17 Hamilton Road Ealing
    W5 2EG London
    Segretario
    25 Parkside
    17 Hamilton Road Ealing
    W5 2EG London
    British39298940001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Segretario
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    STOKES, Martin Howard
    1 Hazel Grove
    SO22 4PQ Winchester
    Hampshire
    Segretario
    1 Hazel Grove
    SO22 4PQ Winchester
    Hampshire
    British7345750001
    AYRE, Timothy Andrew
    14 Ridgmont Road
    AL1 3AF St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 Ridgmont Road
    AL1 3AF St Albans
    Hertfordshire
    British1440830002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish32809050044
    BERGIN, Gavin Joseph
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish251327820001
    BLUNDELL, Roger Frederick Crawford
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    Amministratore
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    EnglandBritish56525730002
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Amministratore
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritish152497530001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Amministratore
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Amministratore
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritish170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Amministratore
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritish78691990003
    COLEMAN, David Michael
    Downings 18 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BW Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Downings 18 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BW Sevenoaks
    Kent
    British2305220001
    CREEDY, Mark Peter
    18 The Broadwalk
    HA6 2XD Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    18 The Broadwalk
    HA6 2XD Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11841300002
    CUTT, Michael Caslake
    Cedar House
    Coombe Lane Sunninghill
    SL5 7AT Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Cedar House
    Coombe Lane Sunninghill
    SL5 7AT Ascot
    Berkshire
    British72423090001
    ELLIOTT, Mark Steven
    1 Elmwood
    AL8 6LD Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Elmwood
    AL8 6LD Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish59140240001
    FLEMING, Keith
    Dairy Cottage, Church Barns
    Church Bank Road, East Stratton
    SO21 3XA Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Dairy Cottage, Church Barns
    Church Bank Road, East Stratton
    SO21 3XA Winchester
    Hampshire
    British96487450002
    GARDEN, Ian Graham
    10 Prairie Street
    SW8 3PU London
    Amministratore
    10 Prairie Street
    SW8 3PU London
    British64361460001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    HARTWELL, Terrance
    Brambledene
    231 Winchester Road
    SO53 2DX Chandlers Ford
    Hampshire
    Amministratore
    Brambledene
    231 Winchester Road
    SO53 2DX Chandlers Ford
    Hampshire
    United KingdomBritish147043140001
    HARTWELL, Terrance
    Brambledene
    231 Winchester Road
    SO53 2DX Chandlers Ford
    Hampshire
    Amministratore
    Brambledene
    231 Winchester Road
    SO53 2DX Chandlers Ford
    Hampshire
    United KingdomBritish147043140001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Amministratore
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    British51688320001
    JAMES, Bruce Michael
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Amministratore
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritish226746900001
    JONES, Alan Arnold
    Laurel Cottages
    Pump Meadow
    HP16 9EW Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Laurel Cottages
    Pump Meadow
    HP16 9EW Great Missenden
    Buckinghamshire
    British1440820003
    JONES, Amanda Jane
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Amministratore
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish73507000004
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Amministratore
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    LIGHT, Arthur Nicolas
    88 Peperharow Road
    GU7 2PN Godalming
    Surrey
    Amministratore
    88 Peperharow Road
    GU7 2PN Godalming
    Surrey
    British851100001
    LIGHT, Arthur Nicolas
    88 Peperharow Road
    GU7 2PN Godalming
    Surrey
    Amministratore
    88 Peperharow Road
    GU7 2PN Godalming
    Surrey
    British851100001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Project Sunrise Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 apr 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 26 feb 2003
    Consegnato il 13 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The freehold property known as land and buildings on the south west side of solatron road farnborough hampshire title number HP512803, together with all buildings structures trade fixtures and fixed plant and machinery owned by the chargor at any time on such property and all improvements and additions to such property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0