PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02043282 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CHARTWELL LAND PROPERTIES LIMITED | 05 feb 1999 | 05 feb 1999 |
| CHARTWELL LAND OPERATIONAL PROPERTIES LIMITED | 23 ott 1998 | 23 ott 1998 |
| CHARTWELL DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED | 18 apr 1988 | 18 apr 1988 |
| WOOLWORTH PROPERTIES (MANAGEMENT) LIMITED | 03 dic 1986 | 03 dic 1986 |
| LEGIBUS 747 LIMITED | 04 ago 1986 | 04 ago 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Cessazione della carica di Amanda Jane Jones come amministratore in data 08 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Jonathan Charles Mcnuff come amministratore in data 03 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Gavin Bergin come amministratore in data 03 nov 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2022 | 15 pagine | AA | ||
legacy | 251 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
Cessazione della carica di Charles John Middleton come amministratore in data 31 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Amanda Jane Jones come amministratore in data 18 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Bruce Michael James come amministratore in data 31 dic 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 3 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Gavin Bergin come amministratore in data 29 mar 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Nick Taunt come amministratore in data 05 ott 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Tom Robson come amministratore in data 11 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 3 pagine | AA | ||
Nomina di Josephine Hayman come amministratore in data 31 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Tom Robson come amministratore in data 31 gen 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 3 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| HAYMAN, Josephine | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 266797860001 | |||||||||
| TAUNT, Nicholas Henry | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 275050860001 | |||||||||
| CLIFTON, Sally Jane | Segretario | Braeside Old Micheldever Road SP11 7AF Longparish Hampshire | British | 77925190001 | ||||||||||
| EKPO, Ndiana | Segretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
| ENOCH, Simon Jocelyn | Segretario | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | British | 61314280001 | ||||||||||
| LAWLEY, Anne Katharine | Segretario | 25 Parkside 17 Hamilton Road Ealing W5 2EG London | British | 39298940001 | ||||||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Segretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Segretario | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||||||
| STOKES, Martin Howard | Segretario | 1 Hazel Grove SO22 4PQ Winchester Hampshire | British | 7345750001 | ||||||||||
| AYRE, Timothy Andrew | Amministratore | 14 Ridgmont Road AL1 3AF St Albans Hertfordshire | British | 1440830002 | ||||||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||||||
| BELL, Lucinda Margaret | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | 32809050044 | |||||||||
| BERGIN, Gavin Joseph | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 251327820001 | |||||||||
| BLUNDELL, Roger Frederick Crawford | Amministratore | Vineyard Hill Road SW19 7JL London 61 | England | British | 56525730002 | |||||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Amministratore | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||||||
| BURGESS, Richard John | Amministratore | 54 Manor Road SM2 7AG Cheam Surrey | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | 35427700001 | |||||||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Amministratore | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Amministratore | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||||||
| COLEMAN, David Michael | Amministratore | Downings 18 Uplands Way Riverhead TN13 3BW Sevenoaks Kent | British | 2305220001 | ||||||||||
| CREEDY, Mark Peter | Amministratore | 18 The Broadwalk HA6 2XD Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11841300002 | |||||||||
| CUTT, Michael Caslake | Amministratore | Cedar House Coombe Lane Sunninghill SL5 7AT Ascot Berkshire | British | 72423090001 | ||||||||||
| ELLIOTT, Mark Steven | Amministratore | 1 Elmwood AL8 6LD Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | 59140240001 | |||||||||
| FLEMING, Keith | Amministratore | Dairy Cottage, Church Barns Church Bank Road, East Stratton SO21 3XA Winchester Hampshire | British | 96487450002 | ||||||||||
| GARDEN, Ian Graham | Amministratore | 10 Prairie Street SW8 3PU London | British | 64361460001 | ||||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| HARTWELL, Terrance | Amministratore | Brambledene 231 Winchester Road SO53 2DX Chandlers Ford Hampshire | United Kingdom | British | 147043140001 | |||||||||
| HARTWELL, Terrance | Amministratore | Brambledene 231 Winchester Road SO53 2DX Chandlers Ford Hampshire | United Kingdom | British | 147043140001 | |||||||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Amministratore | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||||||
| JAMES, Bruce Michael | Amministratore | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 226746900001 | |||||||||
| JONES, Alan Arnold | Amministratore | Laurel Cottages Pump Meadow HP16 9EW Great Missenden Buckinghamshire | British | 1440820003 | ||||||||||
| JONES, Amanda Jane | Amministratore | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 73507000004 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Amministratore | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| LIGHT, Arthur Nicolas | Amministratore | 88 Peperharow Road GU7 2PN Godalming Surrey | British | 851100001 | ||||||||||
| LIGHT, Arthur Nicolas | Amministratore | 88 Peperharow Road GU7 2PN Godalming Surrey | British | 851100001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project Sunrise Limited | 06 apr 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
PROJECT SUNRISE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Creato il 26 feb 2003 Consegnato il 13 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The freehold property known as land and buildings on the south west side of solatron road farnborough hampshire title number HP512803, together with all buildings structures trade fixtures and fixed plant and machinery owned by the chargor at any time on such property and all improvements and additions to such property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0