LAMBERTS (DALSTON) LIMITED

LAMBERTS (DALSTON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLAMBERTS (DALSTON) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02051235
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LAMBERTS (DALSTON) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova LAMBERTS (DALSTON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LAMBERTS (DALSTON) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ESTANT LIMITED01 set 198601 set 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di LAMBERTS (DALSTON) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LAMBERTS (DALSTON) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LAMBERTS (DALSTON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 25 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 16 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2016

    Stato del capitale al 03 feb 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Leslie Deacon il 15 set 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Redmond Mcevoy il 15 set 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Conor Francis Costigan il 15 set 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2015

    2 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mag 2015 al 31 mar 2015

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2014

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2015

    Stato del capitale al 19 gen 2015

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2014 al 31 mag 2014

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di David Frank Armstrong come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hugh Hamer come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Armstrong come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Leslie Deacon come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di David Frank Armstrong come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Redmond Mcevoy come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Conor Francis Costigan come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 lug 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 gen 2014

    Stato del capitale al 17 gen 2014

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di LAMBERTS (DALSTON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COSTIGAN, Conor Francis
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    Amministratore
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    IrelandIrishDirector143611730017
    DEACON, Leslie
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    Amministratore
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant188311390002
    MCEVOY, Redmond
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    Amministratore
    Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Dcc House
    Leinster
    Ireland
    IrelandIrishDirector152703040008
    ARMSTRONG, William
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    Segretario
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    161970630001
    BOWSER, Helen Glenys
    11 Egerton Road
    OX10 0HL Wallingford
    Oxfordshire
    Segretario
    11 Egerton Road
    OX10 0HL Wallingford
    Oxfordshire
    BritishAccountant62058400001
    CLARKE, Kevin Patrick
    28 Crail View
    GL54 3QH Northleach
    Gloucestershire
    Segretario
    28 Crail View
    GL54 3QH Northleach
    Gloucestershire
    British74268640001
    GIBBONS, John Patrick
    45 Park Mount
    AL5 3AS Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    45 Park Mount
    AL5 3AS Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector72851390001
    JONES, Huw Wyndham Lloyd
    Larchfield House
    Pregge Lane
    NP8 1SE Crickhowell
    Powys
    Segretario
    Larchfield House
    Pregge Lane
    NP8 1SE Crickhowell
    Powys
    BritishChartered Accountant65145590002
    KERR, Vincent Brian
    The Folly
    Whitebrook
    NP25 4TU Monmouth
    Gwent
    Segretario
    The Folly
    Whitebrook
    NP25 4TU Monmouth
    Gwent
    BritishDirector122160340001
    MULCAHY, Patrick John
    2 Trinity Lane
    Caerleon
    NP18 3SZ Newport
    Gwent
    Segretario
    2 Trinity Lane
    Caerleon
    NP18 3SZ Newport
    Gwent
    BritishFinance Director58034380001
    SNOW, Gordon
    91 Ferry Road
    OX3 0EX Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    91 Ferry Road
    OX3 0EX Oxford
    Oxfordshire
    British116227430001
    TEMBE, George
    45 Southdown Road
    AL5 1PG Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    45 Southdown Road
    AL5 1PG Harpenden
    Hertfordshire
    British22557610001
    WILLIAMS, Robin Vaughan
    Craiglas House
    Talybont On Usk
    LD3 7YU Brecon
    Powys
    Segretario
    Craiglas House
    Talybont On Usk
    LD3 7YU Brecon
    Powys
    BritishChairman56290860001
    ARMSTRONG, David Frank
    Brewery Road
    Stillorgan
    Dcc House
    Co. Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Brewery Road
    Stillorgan
    Dcc House
    Co. Dublin
    Ireland
    EnglandBritishGroup Managing Director - Dcc Vital149576040001
    CLARKE, Kevin Patrick
    28 Crail View
    GL54 3QH Northleach
    Gloucestershire
    Amministratore
    28 Crail View
    GL54 3QH Northleach
    Gloucestershire
    BritishCompany Secretary74268640001
    COX, Robert Lewis
    75 High Street
    Prestwood
    HP16 9EJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    75 High Street
    Prestwood
    HP16 9EJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    BritishManaging Director87723650001
    DAY, Haydn Reginald
    Old Southgate
    Luton Road
    AL5 Harpenden
    Herts
    Amministratore
    Old Southgate
    Luton Road
    AL5 Harpenden
    Herts
    BritishDirector22557620001
    DRYDEN, Henry Spencer
    26 Ridgewood Drive
    AL5 3LE Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    26 Ridgewood Drive
    AL5 3LE Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector22235620001
    DUNN, Steve
    39 Leam Terrace
    CV31 1BQ Royal Leamington Spa
    Florence House
    Amministratore
    39 Leam Terrace
    CV31 1BQ Royal Leamington Spa
    Florence House
    EnglandBritishCeo138547030001
    GIBBONS, John Patrick
    45 Park Mount
    AL5 3AS Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    45 Park Mount
    AL5 3AS Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector72851390001
    GORDON-PICKING, Bruce
    71 Ambler Road
    Finsbury Park
    N4 2QS London
    Amministratore
    71 Ambler Road
    Finsbury Park
    N4 2QS London
    BritishChartered Accountant49988380006
    HAMER, Hugh Lloyd
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    Amministratore
    Craiglas House
    Maerdy Industrial Estate
    NP22 5PY Rhymney, Tredegar
    Gwent
    WalesBritishDirector164602910001
    HILL, John Rendel
    Woodredon
    64 West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Woodredon
    64 West Common
    AL5 2LD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector5678770001
    JONES, Huw Wyndham Lloyd
    Larchfield House
    Pregge Lane
    NP8 1SE Crickhowell
    Powys
    Amministratore
    Larchfield House
    Pregge Lane
    NP8 1SE Crickhowell
    Powys
    WalesBritishFinancial Director65145590002
    KERR, Vincent Brian
    Folly House
    Whitebrook
    NP25 4TU Monmouth
    Gwent
    Amministratore
    Folly House
    Whitebrook
    NP25 4TU Monmouth
    Gwent
    WalesBritishManaging Director68341340001
    KNIGHT, Nigel
    36 Bushbys Park
    L37 2EF Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    36 Bushbys Park
    L37 2EF Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector115578040001
    MULCAHY, Patrick John
    2 Trinity Lane
    Caerleon
    NP18 3SZ Newport
    Gwent
    Amministratore
    2 Trinity Lane
    Caerleon
    NP18 3SZ Newport
    Gwent
    United KingdomBritishFinance Director58034380001
    PARKER, Colin George
    6 Strafford Way
    OX9 3XX Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    6 Strafford Way
    OX9 3XX Thame
    Oxfordshire
    United KingdomBritishManaging Director36526820001
    RAYWOOD, John
    32a West Hill Avenue
    KT19 8JU Epsom
    Surrey
    Amministratore
    32a West Hill Avenue
    KT19 8JU Epsom
    Surrey
    United KingdomBritishExecutive Director78273100001
    SNOW, Gordon
    91 Ferry Road
    OX3 0EX Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    91 Ferry Road
    OX3 0EX Oxford
    Oxfordshire
    BritishDirector Of Admin116227430001
    TEMBE, George
    45 Southdown Road
    AL5 1PG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    45 Southdown Road
    AL5 1PG Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector22557610001
    WEYMAN, Anne Judith
    8 College Cross
    N1 1PP London
    Amministratore
    8 College Cross
    N1 1PP London
    EnglandBritishChief Executive8401940001
    WILLIAMS, Robin Vaughan
    Craiglas House
    Talybont On Usk
    LD3 7YU Brecon
    Powys
    Amministratore
    Craiglas House
    Talybont On Usk
    LD3 7YU Brecon
    Powys
    BritishChairman56290860001

    LAMBERTS (DALSTON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 mar 2005
    Consegnato il 18 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 23 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 set 1986
    Consegnato il 08 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts and uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 16 feb 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0