XMA (HOLDINGS) LIMITED

XMA (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàXMA (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02052196
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di XMA (HOLDINGS) LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova XMA (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wilford Industrial Estate
    Ruddington Lane,Wilford
    NG11 7EP Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di XMA (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WALDONFELL LIMITED03 set 198603 set 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di XMA (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per XMA (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 26 set 2012

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    Bilancio annuale redatto al 07 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Christine Batchelor come segretario in data 31 gen 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Simon Edward Perret come amministratore in data 31 gen 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Edward Perret come segretario in data 31 gen 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    10 pagineAA

    Nomina di Mrs Christine Batchelor come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    11 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 07 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    11 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    11 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di XMA (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BATCHELOR, Christine
    Wilford Industrial Estate
    Ruddington Lane,Wilford
    NG11 7EP Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Wilford Industrial Estate
    Ruddington Lane,Wilford
    NG11 7EP Nottingham
    Nottinghamshire
    166598220001
    BATCHELOR, Christine
    Wilford Industrial Estate
    Ruddington Lane,Wilford
    NG11 7EP Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Wilford Industrial Estate
    Ruddington Lane,Wilford
    NG11 7EP Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish153241410001
    FORSYTH, Duncan Gavin, Mr.
    21 Chazey Road
    Caversham
    RG4 7DS Reading
    Berkshire
    Amministratore
    21 Chazey Road
    Caversham
    RG4 7DS Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish108380160001
    MADHANI, Sunil Jayantilal
    5 Heron Place
    Harefield
    UB9 6TA Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    5 Heron Place
    Harefield
    UB9 6TA Uxbridge
    Middlesex
    EnglandBritish101754170001
    PEARSON, Richard Barrett
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    British121732790001
    PERRET, Simon Edward
    2 Ullswater Avenue
    Barrow On Soar
    LE12 8QR Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    2 Ullswater Avenue
    Barrow On Soar
    LE12 8QR Loughborough
    Leicestershire
    British26612310001
    IRWIN, Clifford Edward
    South Haining
    Brockenhurst Road
    SL5 9HB Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    South Haining
    Brockenhurst Road
    SL5 9HB Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish80267740001
    LOWE, Peter Frederick
    The Grange
    St Hilary
    CF71 7DP Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Amministratore
    The Grange
    St Hilary
    CF71 7DP Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritish1632340001
    MANSWORTH, Kevin Thomas
    44 Banks Cottage
    The Banks Bingham
    NG13 8BT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    44 Banks Cottage
    The Banks Bingham
    NG13 8BT Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish25275050007
    MANSWORTH, Thomas Walter
    88 Walcote Drive
    West Bridgford
    NG2 7GS Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    88 Walcote Drive
    West Bridgford
    NG2 7GS Nottingham
    Nottinghamshire
    British25275060001
    MILLS, Ronald Gerald
    10 Vine Acre
    NP25 3HW Monmouth
    Gwent
    Amministratore
    10 Vine Acre
    NP25 3HW Monmouth
    Gwent
    British46856130001
    PEARSON, Richard Barrett
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish121732790001
    PERRET, Simon Edward
    2 Ullswater Avenue
    Barrow On Soar
    LE12 8QR Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    2 Ullswater Avenue
    Barrow On Soar
    LE12 8QR Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish26612310001

    XMA (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 lug 2010
    Consegnato il 05 ago 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 mar 1996
    Consegnato il 28 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0