GOODLANDS HOLDINGS LIMITED

GOODLANDS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGOODLANDS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02052237
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GOODLANDS HOLDINGS LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova GOODLANDS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O
    MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GOODLANDS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    S W EIGHTY THREE COMPANY LIMITED03 set 198603 set 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di GOODLANDS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per GOODLANDS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Cessazione della carica di Paul Nigel Hampden Smith come amministratore in data 28 feb 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Nigel Hampden Smith come amministratore in data 28 feb 2013

    1 pagineTM01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Travis Perkins Trading Co Ltd Lodge Way, Lodge Farm Industrial Es, Northampton Northamptonshire NN5 7UG in data 21 dic 2011

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 dic 2011

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 ott 2011

    Stato del capitale al 11 ott 2011

    • Capitale: GBP 1,521,603
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    1 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    1 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    1 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    1 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    1 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di GOODLANDS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Segretario
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish104472550001
    BACON, Timothy Reginald
    1 Wendover Gardens
    Christchurch
    GL50 2PA Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    1 Wendover Gardens
    Christchurch
    GL50 2PA Cheltenham
    Gloucestershire
    British11336800001
    BUCKMAN, Keith Roy
    4 Hamber Lea
    Bishops Lydeard
    TA4 3NJ Taunton
    Somerset
    Segretario
    4 Hamber Lea
    Bishops Lydeard
    TA4 3NJ Taunton
    Somerset
    British16092300001
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    British104472550001
    BACON, Timothy Reginald
    1 Wendover Gardens
    Christchurch
    GL50 2PA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    1 Wendover Gardens
    Christchurch
    GL50 2PA Cheltenham
    Gloucestershire
    British11336800001
    BUCKMAN, Keith Roy
    4 Hamber Lea
    Bishops Lydeard
    TA4 3NJ Taunton
    Somerset
    Amministratore
    4 Hamber Lea
    Bishops Lydeard
    TA4 3NJ Taunton
    Somerset
    British16092300001
    DONALD, Robin Vyvyan Carter
    Osborne House Bathampton Lane
    BA2 6SW Bath
    Avon
    Amministratore
    Osborne House Bathampton Lane
    BA2 6SW Bath
    Avon
    British19164040001
    FISHER, Charles Murray
    Warneford House
    Sudgrove
    GL6 7JD Miserden
    Gloucestershire
    Amministratore
    Warneford House
    Sudgrove
    GL6 7JD Miserden
    Gloucestershire
    United KingdomBritish74765660002
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    MCKAY, Francis John
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    British78787530001
    MORGAN, Keith Douglas
    Long Meadow
    Blagdon Hill
    TA3 7SF Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Long Meadow
    Blagdon Hill
    TA3 7SF Taunton
    Somerset
    British19164050001
    OTLEY, Nicholas William
    Blacknest Farm
    Hinton Blewitt Temple Cloud
    BS39 5AL Bristol
    Avon
    Amministratore
    Blacknest Farm
    Hinton Blewitt Temple Cloud
    BS39 5AL Bristol
    Avon
    British11394040001
    WARES, Hugh David Mcdonald
    12 Old Sneed Park
    BS9 1RF Bristol
    Amministratore
    12 Old Sneed Park
    BS9 1RF Bristol
    British84123870001

    GOODLANDS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Collateral debenture
    Creato il 29 nov 1994
    Consegnato il 03 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from velocity 168 limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of life policy
    Creato il 29 nov 1994
    Consegnato il 01 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Policy of assurance on the life of keith douglas morgan with sun alliance and london assurance company limited no: 9145540. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of life policy
    Creato il 29 nov 1994
    Consegnato il 01 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Policy of assurance on the life of nicholas william otley with phoenix assurance PLC numbered 1529537F. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of life policy
    Creato il 29 nov 1994
    Consegnato il 01 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the policy of assurance on the life of keith roy buckham with sun alliance and london assurance company limited no: 9145533. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 nov 1994
    Consegnato il 18 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property being land and buildings at priory road wells somerset t/no.ST65155 and all buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 gen 1990
    Consegnato il 03 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property at blundells road, tiverton & all buildings & fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 05 giu 1989
    Consegnato il 13 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises at audley road chippenham wilts & all buildings fixtures plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 mag 1989
    Consegnato il 02 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge by way of legal mortgage and all that f/h premises at brushfordd dulverton.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1989
    Consegnato il 26 mag 1989
    In corso
    Importo garantito
    £30,000 due from the company to burton safe deposit & trust company limited
    Brevi particolari
    Third floor flat 48 queensgate terrace, kensington london SW7.
    Persone aventi diritto
    • Boston Safe Deposite & Trust Company Limited
    Transazioni
    • 26 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1989
    Consegnato il 09 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at churchlands rd bedminster bristol avon together with fixed plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1989
    Consegnato il 09 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at churchlands road bedminster bristol avon title no av 2866. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1989
    Consegnato il 09 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at west street and osborne terrace bedminster bristol avon t/no av 2865. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1989
    Consegnato il 09 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at west street bedminster bristol avon title no av 77194. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1989
    Consegnato il 09 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at bludells road tiverton. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1989
    Consegnato il 09 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at mont road minehead. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1989
    Consegnato il 09 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H premises at williton industrial estate. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1989
    Consegnato il 09 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H office & yard at station road williton. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 30 apr 1989
    Consegnato il 05 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 gen 1989
    Consegnato il 21 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of agreement dated 19.12.88
    Brevi particolari
    Stock in trade, work in progress, prepayments, investments quoted on a recognised stock exchange and cash both present & future.
    Persone aventi diritto
    • Ronald Walkins
    Transazioni
    • 21 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 30 apr 1987
    Consegnato il 06 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 apr 1987
    Consegnato il 05 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stock-in-trade, work-in-progress, pre-payment investments & cash.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GOODLANDS HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 dic 2011Inizio della liquidazione
    25 apr 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Alistair Steven Wood
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Praticante
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0