EXOTIX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXOTIX LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02056541
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di EXOTIX LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova EXOTIX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor 39 Sloane Street
    SW1X 9LP London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXOTIX LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EXCO SECURITIES UK LIMITED01 ott 199601 ott 1996
    EXCO DERIVATIVES UK LIMITED04 mar 199604 mar 1996
    GODSELL ASTLEY & PEARCE (DERIVATIVE PRODUCTS) LIMITED02 gen 199102 gen 1991
    GODSELL, ASTLEY & PEARCE (CAPITAL MARKETS) LIMITED28 set 198828 set 1988
    EXCO CAPITAL MARKETS LIMITED17 ott 198617 ott 1986
    MERLEWAYS LIMITED19 set 198619 set 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXOTIX LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per EXOTIX LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al04 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma18 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al04 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per EXOTIX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XD84V97F

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2023

    3 pagineAA
    XCWCHVNC

    Indirizzo della sede legale modificato da 34-37 Liverpool Street London EC2M 7PP England a 3rd Floor 39 Sloane Street London SW1X 9LP in data 21 dic 2023

    1 pagineAD01
    XCIV9UND

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XCGTUJZL

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2022

    3 pagineAA
    XC0HDCE8

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04
    XC0H8IAH

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Long Lane London SE1 4PG England a 34-37 Liverpool Street London EC2M 7PP in data 26 set 2022

    1 pagineAD01
    XBDCAOP6

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XB7ZXHD9

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2021

    3 pagineAA
    XAYWGJNT

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XA6RMXAR

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2020

    3 pagineAA
    XA6E9J37

    Cessazione della carica di Stephen Mark Roberts come amministratore in data 04 gen 2021

    1 pagineTM01
    X9VH7WCQ

    Indirizzo della sede legale modificato da 42-46 Princelet Street London E1 5LP England a 1 Long Lane London SE1 4PG in data 28 ott 2020

    1 pagineAD01
    X9GMGJ14

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X97EOMUB

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2019

    2 pagineAA
    X90SMSFE

    Modifica dei dettagli di Exotix Holdings Limited come persona con controllo significativo il 14 ott 2019

    2 paginePSC05
    X8HQRQU0

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor, Watson House 54 Baker Street London W1U 7BU England a 42-46 Princelet Street London E1 5LP in data 14 ott 2019

    1 pagineAD01
    X8G1PPBK

    Nomina di Mr Stephen Mark Roberts come amministratore in data 22 ago 2019

    2 pagineAP01
    X8CFV522

    Notifica di Exotix Holdings Limited come persona con controllo significativo il 28 set 2018

    2 paginePSC02
    X86XDJRF

    Cessazione di Exotix (1) Limited come persona con controllo significativo il 28 set 2018

    1 paginePSC07
    X86XDIKP

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    X86XDHXS

    Bilancio redatto al 30 giu 2018

    11 pagineAA
    A82JVHMH

    Chi sono gli amministratori di EXOTIX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GELBER, David
    39 Sloane Street
    SW1X 9LP London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    39 Sloane Street
    SW1X 9LP London
    3rd Floor
    England
    United KingdomCanadianDirector9565460001
    ABREHART, Deborah Anne
    37a Lavender Gardens
    SW11 1DJ London
    Segretario
    37a Lavender Gardens
    SW11 1DJ London
    British3219400007
    BROOMFIELD, Helen Frances
    68 Glenwood Gardens
    Gants Hill
    IG2 6XU Ilford
    Essex
    Segretario
    68 Glenwood Gardens
    Gants Hill
    IG2 6XU Ilford
    Essex
    British22174490002
    BURWOOD, Krista Mary
    45 Esmond Road
    Queens Park
    NW6 7HF London
    Segretario
    45 Esmond Road
    Queens Park
    NW6 7HF London
    BritishSecretary56107160002
    CAVENAGH, Teri-Anne
    14 Roy Grove
    TW12 3DN Hampton
    Suite Flat 2,
    England
    Segretario
    14 Roy Grove
    TW12 3DN Hampton
    Suite Flat 2,
    England
    British123607670002
    CLARKE, David Graham
    3 Woodside Road
    KT3 3AH New Malden
    Surrey
    Segretario
    3 Woodside Road
    KT3 3AH New Malden
    Surrey
    British10152770001
    DICKINSON, Kathryn
    31 Jasmine Court
    Woodyates Road
    SE12 9HP London
    Segretario
    31 Jasmine Court
    Woodyates Road
    SE12 9HP London
    British93784140001
    EGGLETON, Jeanette
    Ridgeway Ashurst Drive
    Boxhill
    KT20 7LW Tadworth
    Surrey
    Segretario
    Ridgeway Ashurst Drive
    Boxhill
    KT20 7LW Tadworth
    Surrey
    British51206780001
    PANK, Edward Charles, Dr
    Red Barn Farmhouse
    Shernborne
    PE31 6SB Kings Lynn
    Norfolk
    Segretario
    Red Barn Farmhouse
    Shernborne
    PE31 6SB Kings Lynn
    Norfolk
    BritishCompany Secretary444060001
    PANK, Edward Charles, Dr
    Red Barn Farmhouse
    Shernborne
    PE31 6SB Kings Lynn
    Norfolk
    Segretario
    Red Barn Farmhouse
    Shernborne
    PE31 6SB Kings Lynn
    Norfolk
    BritishCompany Secretary444060001
    CML SECRETARIES LIMITED
    Piries Place
    RH12 1EH Horsham
    2
    West Sussex
    Segretario
    Piries Place
    RH12 1EH Horsham
    2
    West Sussex
    140106940001
    BARTLETT, Peter James
    First Floor
    54 Baker Street
    W1U 7BU London
    Watson House
    Amministratore
    First Floor
    54 Baker Street
    W1U 7BU London
    Watson House
    EnglandBritishBroker61086910002
    CHAPPELL, Andrew Thomas Robert
    First Floor
    54 Baker Street
    W1U 7BU London
    Watson House
    Amministratore
    First Floor
    54 Baker Street
    W1U 7BU London
    Watson House
    United KingdomBritishBanker123342890002
    COLLETT, Ian Keir
    Great Bainden
    Piccadilly Lane
    TN20 6RH Mayfield
    East Sussex
    Amministratore
    Great Bainden
    Piccadilly Lane
    TN20 6RH Mayfield
    East Sussex
    BritishMoneybroker34907550001
    EDGE, Peter John
    Flat 5
    35 Queens Gate Gardens Kensington
    SW7 5RS London
    Amministratore
    Flat 5
    35 Queens Gate Gardens Kensington
    SW7 5RS London
    BritishMoneybroker28055160001
    EVANS, John William Gerald
    2 Badgers Mount
    SS5 4SA Hockley
    Essex
    Amministratore
    2 Badgers Mount
    SS5 4SA Hockley
    Essex
    EnglandBritishDirector14165260001
    GELBER, David
    6 Clorane Gardens
    NW3 7IR London
    Amministratore
    6 Clorane Gardens
    NW3 7IR London
    United KingdomCanadianDirector9565460001
    HAYWARD, Peter Leslie
    Hilldene 26 Crescent Drive
    Shenfield
    CM15 8DN Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Hilldene 26 Crescent Drive
    Shenfield
    CM15 8DN Brentwood
    Essex
    BritishOptions Broker10152780001
    KINNEAR, John Mackay
    Fortescue House
    Ferry Lane
    SL7 2EZ Medmenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Fortescue House
    Ferry Lane
    SL7 2EZ Medmenham
    Buckinghamshire
    BritishMoneybroker71983880002
    LOTT, Geoffrey William
    Lulworth
    Orpington Road
    BR7 6RA Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Lulworth
    Orpington Road
    BR7 6RA Chislehurst
    Kent
    BritishStockbroker46063360001
    MACDONALD, George
    15 Sydney Street
    SW3 6PN London
    Amministratore
    15 Sydney Street
    SW3 6PN London
    AustraliaBritishChief Executive Officer77644060002
    MANSFIELD, Graham
    Riverside Cottage
    Wisley Lane
    GU23 6QJ Wisley
    Surrey
    Amministratore
    Riverside Cottage
    Wisley Lane
    GU23 6QJ Wisley
    Surrey
    United KingdomBritishMoneybroker8538000002
    MANSFIELD, Graham
    Riverside Cottage
    Wisley Lane
    GU23 6QJ Wisley
    Surrey
    Amministratore
    Riverside Cottage
    Wisley Lane
    GU23 6QJ Wisley
    Surrey
    United KingdomBritishMoneybroker8538000002
    MANSFIELD, Graham
    Rostellan Aviary Road
    Pyrford
    GU22 8TH Woking
    Surrey
    Amministratore
    Rostellan Aviary Road
    Pyrford
    GU22 8TH Woking
    Surrey
    BritishMoney Broker8538000001
    OTOOLE, Peter
    Woodlands
    Chieveley High Street, Chieveley
    RG20 8UR Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Woodlands
    Chieveley High Street, Chieveley
    RG20 8UR Newbury
    Berkshire
    IrishBroker53599760003
    PETTIGREW, James Neilson, Mr.
    Park Avenue South
    AL5 2EA Harpenden
    6
    Hertfordshire
    Amministratore
    Park Avenue South
    AL5 2EA Harpenden
    6
    Hertfordshire
    EnglandBritishDir (Finance)62408210001
    ROBERTS, Simon Leslie
    8 Quay Side
    Westferry Road
    E14 8JT London
    Amministratore
    8 Quay Side
    Westferry Road
    E14 8JT London
    BritishBroker54809270001
    ROBERTS, Stephen Mark
    Long Lane
    SE1 4PG London
    1
    England
    Amministratore
    Long Lane
    SE1 4PG London
    1
    England
    EnglandBritishDirector277697630001
    ROBLIN, Gareth David
    8 Wood Vale
    N10 3DP London
    Amministratore
    8 Wood Vale
    N10 3DP London
    BritishChartered Accountant41992640004
    ROBLIN, Gareth David
    8 Wood Vale
    N10 3DP London
    Amministratore
    8 Wood Vale
    N10 3DP London
    BritishChartered Accountant41992640004
    ROSE, Timothy John
    Park Road
    Ardleigh
    CO7 7SP Colchester
    Ardleigh Park
    Essex
    Amministratore
    Park Road
    Ardleigh
    CO7 7SP Colchester
    Ardleigh Park
    Essex
    EnglandBritishCompany Director135142240001
    SMITH, William Graham
    14 Freeman Way
    Emerson Park
    RM11 3PH Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    14 Freeman Way
    Emerson Park
    RM11 3PH Hornchurch
    Essex
    BritishMoneybroker43915690001
    THORNLEY-HALL, David James
    91 Wardo Avenue
    SW6 6RB London
    Amministratore
    91 Wardo Avenue
    SW6 6RB London
    CanadianSecurities Broker65048520001
    THORP, Simon Austen
    Robeys Farmhouse Brown Candover
    SO24 9TN Alresford
    Hampshire
    Amministratore
    Robeys Farmhouse Brown Candover
    SO24 9TN Alresford
    Hampshire
    BritishSecurities Broker52832370001
    TIETZE, Hans Michael
    Renteilichtung 92
    45134 Essen
    West Germany
    Amministratore
    Renteilichtung 92
    45134 Essen
    West Germany
    GermanManaging Director48973770001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EXOTIX LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Exotix Holdings Limited
    Princelet Street
    E1 5LP London
    42-46
    England
    28 set 2018
    Princelet Street
    E1 5LP London
    42-46
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneLondon
    Numero di registrazione06112861
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Exotix (1) Limited
    Baker Street
    W1U 7BU London
    1st Floor, Watson House
    England
    06 apr 2016
    Baker Street
    W1U 7BU London
    1st Floor, Watson House
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneLondon
    Numero di registrazione07214382
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    EXOTIX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 mar 2007
    Consegnato il 05 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging companies (or any of them) to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Intercapital PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 15 nov 2004
    Consegnato il 20 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re exotix limited and numbered 0019750 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 27 mag 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated ltsb re exotix LTD and numbered 1550085 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division on the name of the bank re the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Custody agreement
    Creato il 02 set 1996
    Consegnato il 09 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the custody agreement
    Brevi particolari
    All the cash from time to time in the cash account, all the shares, stocks, bonds, notes, debentures and other securities held for the account.
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas
    Transazioni
    • 09 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0