WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC

WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 02058427
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WATERFORD WEDGWOOD HOLDINGS PLC 21 ott 198621 ott 1986
    DAYOFFER PUBLIC LIMITED COMPANY 25 set 198625 set 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2009
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ott 2009
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    38 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 mag 2016

    46 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2015

    57 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2014

    62 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2013

    58 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:order of court removing angus matthew martin as liquidator of the company
    9 pagineLIQ MISC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 mag 2012

    46 pagine4.68

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:form 2.39B notice of vacation of office
    15 pagineLIQ MISC

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    26 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 gen 2011

    50 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 lug 2010

    54 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 gen 2010

    27 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 gen 2010

    2 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 gen 2010

    49 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    legacy

    3 pagineMG02

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 lug 2009

    59 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 lug 2009

    30 pagine2.24B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DOWLING, Patrick John
    21 Raglan Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Segretario
    21 Raglan Road
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Irish29859260001
    DOWNIE, Mark Lindsay
    Bassett Close
    Cheadle
    ST10 1UU Stoke-On-Trent
    17
    Staffordshire
    Segretario
    Bassett Close
    Cheadle
    ST10 1UU Stoke-On-Trent
    17
    Staffordshire
    British128949130001
    JENNINGS, Wendy Joy
    189 Aston Village
    Pipe Gate
    TF9 4JF Market Drayton
    Shropshire
    Segretario
    189 Aston Village
    Pipe Gate
    TF9 4JF Market Drayton
    Shropshire
    British8248520001
    STONIER, George
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    British8248550001
    ASHWELL, Kneale Holland
    6 Clarence Crescent
    SL4 5DT Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    6 Clarence Crescent
    SL4 5DT Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish52176650002
    BARNES, Richard Anthony
    Hillside Minn Bank
    Willoughbridge
    TF9 4EU Market Drayton
    Shropshire
    Amministratore
    Hillside Minn Bank
    Willoughbridge
    TF9 4EU Market Drayton
    Shropshire
    EnglandBritish9859220001
    BRENNAN, Donald P
    Hoaglands Lane
    Foxmount Farm Old Brookville
    FOREIGN New York 11545
    Usa
    Amministratore
    Hoaglands Lane
    Foxmount Farm Old Brookville
    FOREIGN New York 11545
    Usa
    American29524290001
    D`ALTON, Paul Michael
    Adare
    Carrickbrennan Road
    IRISH Monkstown
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Adare
    Carrickbrennan Road
    IRISH Monkstown
    County Dublin
    Ireland
    British43460730001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish114320980001
    GAVIN, Moira
    15 Eaton Square
    SW1W 9DD London
    Amministratore
    15 Eaton Square
    SW1W 9DD London
    American94611370002
    GLEDHILL, Hugh Thomas Orlando
    Aston Grange Aston
    ST15 0BJ Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    Aston Grange Aston
    ST15 0BJ Stone
    Staffordshire
    United KingdomBritish29524300001
    GOULANDRIS, Peter John
    Sea Saga,Edgewater Drive
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    Amministratore
    Sea Saga,Edgewater Drive
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    BahamasBahamian62854330004
    GUILLAUMIN, Denis
    35 Princes Gate Court
    SW7 2QJ London
    Amministratore
    35 Princes Gate Court
    SW7 2QJ London
    French55923040002
    HAIG, Gavin
    44 Marsh Lane
    CW5 5LH Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    44 Marsh Lane
    CW5 5LH Nantwich
    Cheshire
    British68733980001
    HARPER, Timothy Wallace
    Hillcroft
    Stoney Lane, Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Hillcroft
    Stoney Lane, Endon
    ST9 9BX Stoke On Trent
    Staffordshire
    British68733880002
    HICK, Paul Arney
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Millcourt Mill Road
    SL7 1QB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish47699120005
    JENNER, Edward
    Moorside 6 Pipers Lane
    Lower Heswell
    L60 9HP Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Moorside 6 Pipers Lane
    Lower Heswell
    L60 9HP Wirral
    Merseyside
    British41630860001
    JOHNSON, Christopher John Staley
    Kibblestone House
    Oulton Heath
    ST15 8US Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    Kibblestone House
    Oulton Heath
    ST15 8US Stone
    Staffordshire
    British8248530001
    JOHNSON, Robert Lewis
    The Old Smithy Gorsey Bank
    Standon
    ST21 6RB Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    The Old Smithy Gorsey Bank
    Standon
    ST21 6RB Stafford
    Staffordshire
    British8248540001
    LITTLE, Roger Forsyth
    Dayhills House
    ST15 7RU Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    Dayhills House
    ST15 7RU Stone
    Staffordshire
    Australian117682010001
    MCGILLIVARY, Christopher John
    3864 West Gulf Drive
    Sanibel Island
    Florida
    33957
    United States
    Amministratore
    3864 West Gulf Drive
    Sanibel Island
    Florida
    33957
    United States
    American117682040001
    MCGORAN, Kevin Columba
    Longwood
    7 Herbert Park
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Amministratore
    Longwood
    7 Herbert Park
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    IrelandIrish15442070001
    NIEHAUS, Robert Henry
    105 Evergreen Avenue
    Rye New York 10580
    FOREIGN United States Of America
    Amministratore
    105 Evergreen Avenue
    Rye New York 10580
    FOREIGN United States Of America
    American46823720002
    NUTBEEN, Wayne Jonathan
    The Kent
    Highgrove House Ancoates Lane
    SK9 7TT Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    The Kent
    Highgrove House Ancoates Lane
    SK9 7TT Alderley Edge
    Cheshire
    British63586300004
    O'DONOGHUE, Patrick Redmond
    Cranmore
    Ballinakill Court Dunmore Road
    Waterford Ireland
    Amministratore
    Cranmore
    Ballinakill Court Dunmore Road
    Waterford Ireland
    Irish77402680001
    O'HAGAN, Leonard John Patrick
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Moyallen
    11 Elton Park
    IRISH Sandycove
    County Dublin
    Ireland
    Irish15365240001
    O'REILLY, Anthony John Francis
    Castlemartin
    Kilcullen
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Amministratore
    Castlemartin
    Kilcullen
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish46823690001
    O'REILLY, Chryssanthie Jane
    Lissadell
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    Amministratore
    Lissadell
    Lyford Cay
    FOREIGN Nassau
    Bahamas
    Greek39590670001
    PATTERSON, Brian David
    8 Trentham Court
    Park Drive Trentham
    ST4 8FB Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    8 Trentham Court
    Park Drive Trentham
    ST4 8FB Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Irish50417460001
    RITCHIE, Robin James
    106 Rodenhurst Road
    SW4 8AP London
    Amministratore
    106 Rodenhurst Road
    SW4 8AP London
    EnglandBritish29524320001
    SMITH, Andrew
    5 Brendon Way
    LE65 1EY Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Amministratore
    5 Brendon Way
    LE65 1EY Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    British60416710002
    STONIER, George
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Hunters Lodge The Common
    Dilhorne
    ST10 2PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish8248550001
    WEDGWOOD, Francis Alan
    Barton House
    Pooley Bridge
    CA10 2NG Penrith
    Cumbria
    Amministratore
    Barton House
    Pooley Bridge
    CA10 2NG Penrith
    Cumbria
    British29524330002
    WEDGWOOD, Piers Anthony Weymouth, Lord
    152
    Ashley Gardens
    SW1 London
    Amministratore
    152
    Ashley Gardens
    SW1 London
    British56478560002

    WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 15 ago 2008
    Consegnato il 23 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £157,017.90 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its interest in the deposit being £157,017.90 plus other monies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Daejan Investments Limited
    Transazioni
    • 23 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of debenture
    Creato il 20 dic 2005
    Consegnato il 05 gen 2006
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America N.A. (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Securities pledge agreement
    Creato il 20 dic 2005
    Consegnato il 05 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the other creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The securities described in schedule 1.2(a) of the securities pledge agreement (being 363 class b shares in certificate number b-6 of waterford wedgwood canada inc.(the securities)) and any cash dividends options warrants securities instruments or other monies intangibles proceeds or other property received or declared in respect of the securities and all other rights and claims. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America, N.A.
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of accession to a debenture dated 30 september 2004
    Creato il 03 mar 2005
    Consegnato il 10 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All group shares and related rights present or future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wachovia Bank, National Association (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 07 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 07 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An intercreditor and security trust agreement
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 17 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to a senior creditor or to an hyb creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    If the company receives from a third party a payment or distribution which should have been paid to the security trustee or a creditor the company must promptly pay to the security trustee the amount received by it and required to be prepaid any amount so received by the company from the third party shall be held by it on trust until such payment is made any amount so received by the security trustee will be applied against the debt in the order provided for under the intercreditor. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security over shares
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 11 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares, all other shares in the capital of the canadian subsidiary, and all warrants options or pther rights to acquire such shares, all securities instruments negotiable documents of title and other personal property of any kind. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security over shares agreement
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first fixed charge all the shares and by way of a first fixed charge all the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over a bank account
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all of its right title and interest in the accounts (being euro accounts nos. 52711170 and 31706620) and the account balances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The debtor grants to the secured party for the benefit of the creditors a continuing security interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Secured Party)
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 26 nov 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (or any of them) to the creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 28 feb 1994
    Consegnato il 15 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of each of the finance documents and the existing facilities (as defined)
    Brevi particolari
    (I) the shares and all dividends and (ii) all stocks, shares and other securities owned by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental guarantee and debenture
    Creato il 28 feb 1994
    Consegnato il 09 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank (as defined) under the terms of the finance documents and existing facilities defined therein
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 mag 1991
    Consegnato il 03 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the existing facilities or the refinancing agreement of over date.
    Brevi particolari
    (See 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 01 mag 1991
    Consegnato il 03 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under te terms of the refinancing agreement of even date & the indebtedness agreements.
    Brevi particolari
    (See 395 for details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 mag 1991
    Consegnato il 02 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to national westminster bank PLC as agent and trustee for itself and for ech bank (as defined) under the terms of the finance documents and existing facilities defined therein.
    Brevi particolari
    (Please see doc for details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 21 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WATERFORD WEDGWOOD U.K. PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 mag 2011Fine dell'amministrazione
    05 gen 2009Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Angus Matthew Martin
    Abbots House Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Praticante
    Abbots House Abbey Street
    RG1 3BD Reading
    Berkshire
    Neville Barry Khan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Praticante
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Nicholas James Dargan
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Praticante
    Deloitte & Touche Llp
    Athene Place
    EC4A 3BQ 66 Shoe Lane
    London
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Praticante
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    2
    DataTipo
    21 mag 2017Data prevista di scioglimento
    10 mag 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Angus Matthew Martin
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Athene Place, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Praticante
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Neville Barry Khan
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0