GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED

GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02058727
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    • (7222) /
    • (7499) /

    Dove si trova GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1200 Bristol Road South
    Northfield
    B31 2RW Birmingham
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DCS MOTIS LIMITED31 mag 199431 mag 1994
    MOTIS SYSTEMS (UK) LIMITED15 set 198715 set 1987
    LOCKE COMPUTING SERVICES LIMITED18 ago 198718 ago 1987
    DALEVOTE LIMITED26 set 198626 set 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    pagineGAZ2(A)

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2008

    pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    pagineGAZ1(A)

    legacy

    pagine652a

    legacy

    pagine363a

    legacy

    pagine363a

    legacy

    pagine287

    legacy

    pagine190

    legacy

    pagine353

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2006

    pagineAA

    legacy

    pagine287

    legacy

    pagine288a

    legacy

    pagine288b

    legacy

    pagine363a

    legacy

    pagine288a

    legacy

    pagine288a

    legacy

    pagine288b

    legacy

    pagine288b

    legacy

    pagine288b

    legacy

    pagine403a

    legacy

    pagine403a

    legacy

    pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    pagineAA

    legacy

    pagine288b

    Chi sono gli amministratori di GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Segretario
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    American121496770001
    BURNETT, Robert David
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    Amministratore
    Post Oak Run
    77355 Magnolia
    28122
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121495910001
    MOSS, Michael Craig
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    Amministratore
    East Blooming
    Rose Court
    77429 Cypress
    17311
    Texas
    Usa
    United StatesAmerican121496770001
    BATE, Nicholas John
    St James Court 107 Wilderspool Causeway
    WA4 6PS Warrington
    Cheshire
    Segretario
    St James Court 107 Wilderspool Causeway
    WA4 6PS Warrington
    Cheshire
    British10672220001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Segretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Segretario
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Segretario
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    British89866330001
    ROGERS, Wendy Fiona
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    Segretario
    Fulbrook House
    14 West End
    HP22 5TT Weston Turville
    Buckinghamshire
    British72773920003
    SMITH, David Anthony
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    British17924810001
    BROMLEY, Christopher Philip
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    27 Morningside
    Earlsdon
    CV5 6PD Coventry
    West Midlands
    British112670520001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Amministratore
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    United KingdomBritish89866330001
    ELLIS, Nicholas Edward
    Westham Lodge
    Wellesbourne Road
    CV35 8DS Barford
    Warwickshire
    Amministratore
    Westham Lodge
    Wellesbourne Road
    CV35 8DS Barford
    Warwickshire
    United KingdomBritish81206820001
    EMBLEY, Paul
    23 Roosevelt Avenue
    SG17 5UR Shefford
    Bedfordshire
    Amministratore
    23 Roosevelt Avenue
    SG17 5UR Shefford
    Bedfordshire
    British66065980001
    FABRE, Jeremie
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    Amministratore
    4 Rue Du Lac
    Messery
    74140
    France
    French116364550001
    FLEGG, Ronald Edwin
    28 Grange Farm Drive
    Stockton
    CV47 8FT Southam
    Warwickshire
    Amministratore
    28 Grange Farm Drive
    Stockton
    CV47 8FT Southam
    Warwickshire
    British10672250002
    HARRISON, Jeffrey Malcolm
    54 Stratford Road
    B60 1AU Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    54 Stratford Road
    B60 1AU Bromsgrove
    Worcestershire
    British16150470002
    KIDD, John
    10 Ashmeade
    Halebarns
    WA15 0DB Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    10 Ashmeade
    Halebarns
    WA15 0DB Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish10672230001
    MACKENZIE, Iain Robertson
    Corbett House 15 Corbett Avenue
    WR9 7BE Droitwich
    Worcestershire
    Amministratore
    Corbett House 15 Corbett Avenue
    WR9 7BE Droitwich
    Worcestershire
    British35613150001
    MARTIN, Robert Edward
    25 Syddal Road
    Bramhall
    SK7 1AB Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    25 Syddal Road
    Bramhall
    SK7 1AB Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish24767980001
    MERRIMAN, Christopher Peter
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    1 Oakdene Drive
    Barnt Green
    B45 8LQ Birmingham
    West Midlands
    British63578740002
    SANT, Andrew Jonathan
    The Granary
    Marton Road
    CV23 8EH Birdingbury
    Warwickshire
    Amministratore
    The Granary
    Marton Road
    CV23 8EH Birdingbury
    Warwickshire
    British82342040002
    SMITH, David Anthony
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    15 Waveney Drive
    WA14 4UQ Altrincham
    Cheshire
    British17924810001
    SOANES, David
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    Amministratore
    Fencewood House
    Slanting Hill
    RG18 9QQ Cold Ash
    Berkshire
    British80021380001
    SPENCE, Raymond Leslie
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Mill Lane
    WS14 0DP Lichfield
    Staffordshire
    British46677090001
    STERKENBURG, Daniel Richard
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    Amministratore
    Rue De L'Eglise 7
    Crans-Pres-Celigny
    1299
    Switzerland
    American116364510001
    WOODALL, Frederick Peter
    The Ridge Pine Walks
    Prenton
    CH42 8NF Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    The Ridge Pine Walks
    Prenton
    CH42 8NF Wirral
    Merseyside
    British74795530001
    YAPP, Stephen
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    Amministratore
    4 The Tovells
    Off School Lane Ufford
    IP13 6HF Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish42686850001

    GLOBAL AUTOMOTIVE (NORTHERN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 11 ott 2005
    Consegnato il 21 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 mar 2004
    Consegnato il 01 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges over all property & assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, insurances, intellectual property, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 27 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade and tenants fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of copyright and design right
    Creato il 21 feb 1994
    Consegnato il 09 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A)all copyrights and rights in the nature of copyright now belonging to the company throughout the world.b)all design rights now belonging to the company throughout the world.c)all copyrights,design rights and rights in the nature of copyright throughout the world.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over goodwill trade marks and tradenames
    Creato il 21 feb 1994
    Consegnato il 09 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1."Charged rights" means all trade marks,trade mark applications,tradenames and other rights and interests charged.2."trade marks" means united kingdom trade marks,including service marks or where the context requires,the equivalent in other local jurisdictions.by way of fixed charge:-a)all the trade marks listed in the schedule.b)all interests or rights of the company,both present and future in trade marks or tradenames.c)all other goodwill,both present and future,of the company and all tradenames.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 08 nov 1991
    Consegnato il 28 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee d/d 6/11/91 & this charge
    Brevi particolari
    The motis software rights.....the computer programmes....the operating manuels....the media....all rights to the mark and/or name "motis"....please see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abtrust Scotland Investment Company PLC
    Transazioni
    • 28 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 nov 1991
    Consegnato il 28 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee d/d 6/11/91 & this charge
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Abtrust Scotland Investment Company PLC
    Transazioni
    • 28 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 nov 1991
    Consegnato il 28 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 6/11/91 & this charge
    Brevi particolari
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tameside Metropolitan Borough Council
    Transazioni
    • 28 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 08 nov 1991
    Consegnato il 29 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee d/d 6/11/91 and this charge
    Brevi particolari
    The motis software rights....the computer programmes....the operating programmes....the media....all rights to the mark and/or name "motis"....please see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tameside Metropolitan Borough Council
    Transazioni
    • 29 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1989
    Consegnato il 17 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of charge.
    Brevi particolari
    The motis software materials as defined in clause 1 of the assignment. See contribution sheet to ford 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Motis Systems Inc.
    Transazioni
    • 17 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 30 giu 1989
    Consegnato il 17 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the assignment of even date.
    Brevi particolari
    The motis software materials as defined clause 1 of the assignment. See contribution sheet to form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Motis Systems Inc
    Transazioni
    • 17 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 giu 1988
    Consegnato il 11 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 03 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0