BMM (PREDECESSORS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BMM (PREDECESSORS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02060925 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BMM (PREDECESSORS) LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova BMM (PREDECESSORS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o COATS GROUP PLC 1 The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge Middlesex |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BMM (PREDECESSORS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| 02060925 LIMITED | 28 mag 2012 | 28 mag 2012 |
| BM ENGINEERING DIVISION LIMITED | 19 mar 1991 | 19 mar 1991 |
| BM TECHNOLOGIES LIMITED | 02 ott 1986 | 02 ott 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BMM (PREDECESSORS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per BMM (PREDECESSORS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 dic 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Allied Mutual Insurance Services Limited come amministratore in data 23 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Charles Frederick Barlow come amministratore in data 23 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Arif Kermalli come amministratore in data 23 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew James Stockwell come amministratore in data 23 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Rohan Taylor come amministratore in data 23 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin Rohan Taylor come amministratore in data 06 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard David Howes come amministratore in data 06 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Allied Mutual Insurance Services Limited il 03 mar 2015 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Allied Mutual Insurance Services Limited il 03 mar 2015 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Prism Cosec Limited 10 Margaret Street London W1W 8RL a C/O Coats Group Plc 1 the Square Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1TD in data 03 mar 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Richard Howes come amministratore in data 14 lug 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Allied Mutual Insurance Services Limited come segretario in data 30 giu 2014 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas James Tarn come amministratore in data 30 giu 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher William Healy come segretario in data 30 giu 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 78 Pall Mall London SW1Y 5ES England* in data 01 lug 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BMM (PREDECESSORS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIED MUTUAL INSURANCE SERVICES LIMITED | Segretario | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex England |
| 126889420001 | ||||||||||
| BARLOW, Charles Frederick | Amministratore | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | United Kingdom | British | 151336790001 | |||||||||
| KERMALLI, Arif | Amministratore | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | England | British | 203519190001 | |||||||||
| STOCKWELL, Andrew James | Amministratore | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | England | British | 79587890002 | |||||||||
| HEALY, Christopher William | Segretario | c/o Prism Cosec Limited Margaret Street W1W 8RL London 10 England | 187859620001 | |||||||||||
| KING, John Alan Gibbs | Segretario | 10 Ashvale Close Nailsea BS48 1QH Bristol | British | 9313920001 | ||||||||||
| STENNING, David John | Segretario | Woodmans Cottage Blagdon Hill TA3 7SN Taunton Somerset | British | 74979120001 | ||||||||||
| ADAMSON, Michael George | Amministratore | Woodbury Cheniston Grove SL6 4LN Maidenhead Berkshire | British | 56044570001 | ||||||||||
| BARRETT, Barrie Michael | Amministratore | The Firs Spetchley Road WR5 2NL Worcester Worcestershire | British | 4061200002 | ||||||||||
| BLACKBURN, Peter Edward | Amministratore | 20 Church Lane Downend BS16 6TB Bristol Avon | British | 5531260001 | ||||||||||
| BROWNHILL, John | Amministratore | Tree Tops Montacute Road Stoke-Sub-Hamdon TA14 6UQ Yeovil Somerset | British | 4061210001 | ||||||||||
| COLLIER, Albert Ernest | Amministratore | Rose Mount Meare Green Wrantage TA3 6DA Taunton Somerset | British | 20877780001 | ||||||||||
| GLEAVE, Clinton John Raymond | Amministratore | 14 Kenneth Crescent Willesden Green NW2 4PT London | England | British | 48349150003 | |||||||||
| HOWES, Richard David | Amministratore | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex England | England | British | 265695690001 | |||||||||
| JOHNSON, Ronald James | Amministratore | 12 Summer Road Rowley Regis B65 9QQ Warley West Midlands | British | 21552860001 | ||||||||||
| LABRUSSE, Gerard | Amministratore | Chemin Du Buala FOREIGN Borderes-Sur-Echez 65320 France | French | 26325270001 | ||||||||||
| LOFTUS, David John | Amministratore | 48 Oakdale Road Downend BS16 6EA Bristol | England | British | 34443080001 | |||||||||
| LOTT, Alan Charles | Amministratore | Grange Farm House Chestnut Lane Barton In Fabis NG11 0AE Nottingham | British | 28154250001 | ||||||||||
| PETERSEN, Ronald John | Amministratore | Picket Piece Hale Lane Wendover HP22 6NQ Aylesbury Buckinghamshire | England | American | 59083320001 | |||||||||
| RUSSELL, James Richard | Amministratore | The Old Stables Empingham Road PE9 3RP Ketton Rutland | England | British | 904390002 | |||||||||
| SMITH, Nigel John Renton | Amministratore | 13 Oldershaw Avenue Kegworth DE74 2DR Derby | United Kingdom | Uk | 48235590001 | |||||||||
| TAIT, John Andrew Rodney | Amministratore | Honeystone House Fore Street West Camel BA22 7QW Yeovil Somerset | British | 23191860001 | ||||||||||
| TARN, Nicholas James | Amministratore | c/o Prism Cosec Limited Margaret Street W1W 8RL London 10 England | England | British | 113629970001 | |||||||||
| TAYLOR, Kevin Rohan | Amministratore | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex | England | British | 197540030001 | |||||||||
| WALKER, Tom Clifford | Amministratore | Hepburn House Frankleigh BA15 2PF Bradford On Avon Wiltshire | British | 34992860002 | ||||||||||
| ALLIED MUTUAL INSURANCE SERVICES LIMITED | Amministratore | c/o Coats Group Plc The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 Middlesex England |
| 126889420001 | ||||||||||
| BRUNEL HOLDINGS PLC | Amministratore | Brunel House 14 Avon Reach SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 42533420001 | |||||||||||
| CLAYHILL NOMINEES LIMITED | Amministratore | Brunel House 14 Avon Reach SN15 1EE Chippenham Wiltshire | 42533440001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BMM (PREDECESSORS) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S G Warburg Group Limited | 06 apr 2016 | The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Coats Group Plc | 06 apr 2016 | The Square Stockley Park UB11 1TD Uxbridge 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BMM (PREDECESSORS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture deed | Creato il 30 nov 2001 Consegnato il 10 dic 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite debenture between the chargor, brunel holdings PLC, the charging subsidiaries and national westminster bank PLC (as agent and trustee for the finance parties) | Creato il 29 dic 1998 Consegnato il 14 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 apr 1997 Consegnato il 08 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present vand future obligations and liabillties due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) and to the finance parties under each finance document to which such obligor is a party | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite debenture | Creato il 27 set 1993 Consegnato il 14 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due from each obligor (as defined) to the finance parties and to the inter-company chargor lenders (each as defined) under the finance documents and under the assigned inter-company loans | |
Brevi particolari Legal mortgage over certain of the company's real property and over certain of the shares held by it;assignment of rights under certain intercompany loans made by it as lender. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0