HYDE PARK RESIDENCE LIMITED

HYDE PARK RESIDENCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHYDE PARK RESIDENCE LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02061713
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NAPLINK LIMITED06 ott 198606 ott 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al11 lug 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma25 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al11 lug 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2024 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2023

    17 pagineAA

    Nomina di Mr Sebastian Amadeus Moritz come amministratore in data 15 apr 2024

    2 pagineAP01

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08

    Cessazione di Mohamed Al Fayed come persona con controllo significativo il 30 ago 2023

    1 paginePSC07

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Paul Windsor come amministratore in data 16 lug 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Mohamed Al Fayed come persona con controllo significativo il 26 giu 2020

    2 paginePSC01

    Cessazione di Mohamed Al Fayed come persona con controllo significativo il 26 giu 2020

    1 paginePSC07

    Nomina di Mr Andrew Spalton come amministratore in data 19 set 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    25 pagineAA

    Cessazione della carica di Derek Alexander Picot come amministratore in data 01 apr 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Astrid Bray come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Windsor come amministratore in data 07 mar 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mohamad Esreb come amministratore in data 15 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew William Morgan come amministratore in data 31 gen 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORITZ, Sebastian Amadeus
    20 St. Philips Ave
    KT4 8JT Worcester Park
    C/O Moricon Consultants Limited
    England
    Amministratore
    20 St. Philips Ave
    KT4 8JT Worcester Park
    C/O Moricon Consultants Limited
    England
    EnglandBritishConsultant244740630001
    SPALTON, Andrew John
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    EnglandBritishAccountant117413960002
    WATHEN-FAYED, Heini Jasmine
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    United KingdomFinnishDirector209518120001
    BAILY, Rosemary
    179 Ashmore Road
    W9 3DB London
    Segretario
    179 Ashmore Road
    W9 3DB London
    British35407110001
    BROWN, Edgar Lewis
    6 Malthouse Lane
    West End
    GU24 9JF Woking
    Surrey
    Segretario
    6 Malthouse Lane
    West End
    GU24 9JF Woking
    Surrey
    British46031970001
    CRAWFORD, Donald Stewart
    20 Gloucester Road
    Tankerton
    CT5 2DF Whitstable
    Kent
    Segretario
    20 Gloucester Road
    Tankerton
    CT5 2DF Whitstable
    Kent
    BritishCompany Secretary34471810001
    DAVIES, James Ralph Parnell
    24 Batchelors Way
    HP7 9AJ Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    24 Batchelors Way
    HP7 9AJ Amersham
    Buckinghamshire
    British47335710002
    MORGAN, Andrew William
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Segretario
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    British72348270001
    PROSSER, Howell Granville
    90 Peregrine Road
    TW16 6JP Sunbury On Thames
    Middlesex
    Segretario
    90 Peregrine Road
    TW16 6JP Sunbury On Thames
    Middlesex
    British38837860001
    BOZEK, Alison Jane
    26 Sarre Road
    NW2 3SL London
    Amministratore
    26 Sarre Road
    NW2 3SL London
    BritishCompany Director45991620001
    BOZEK, Alison Jane
    26 Sarre Road
    NW2 3SL London
    Amministratore
    26 Sarre Road
    NW2 3SL London
    BritishSecretary45991620001
    BRAY, Astrid
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    EnglandBritishGeneral Manager/Managing Director205745880001
    CRAWFORD, Donald Stewart
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    EnglandBritishAccountant34471810001
    DAVIS, Ronald Ashley Blandford
    160 Straight Road
    Old Windsor
    SL4 2SG Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    160 Straight Road
    Old Windsor
    SL4 2SG Windsor
    Berkshire
    BritishDevelopment Manager44739840001
    ESREB, Mohamad
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    United KingdomBritishBachelor Of Engineering187382940001
    FALLOWFIELD, Robert James
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    EnglandBritishAccountant24469760001
    HOGBEN, Norman Muirhead
    Willow Hayne 46 Chantry View Road
    GU1 3XT Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Willow Hayne 46 Chantry View Road
    GU1 3XT Guildford
    Surrey
    BritishDirector254030001
    KLEIN, Franz Josef
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    FranceGermanHotelier18310070001
    MERRICK, Ian
    Beechcroft
    53 Sidney Road
    KT12 2LZ Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Beechcroft
    53 Sidney Road
    KT12 2LZ Walton On Thames
    Surrey
    BritishGeneral Manager74904320001
    MORGAN, Andrew William
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    EnglandBritishAccountant72348270001
    PICOT, Derek Alexander
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    United KingdomBritishNon Executive Director89605760003
    ROONEY, Tim Patrick
    57 Torbay Road
    NW6 7DU London
    Amministratore
    57 Torbay Road
    NW6 7DU London
    BritishGeneral Manager18268570001
    THOMAS, Francois
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Amministratore
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    United KingdomFrenchDirector160143400001
    TILLMAN, John
    71 Thorntons Farm Avenue
    Rush Green
    RM7 0TS Romford
    Essex
    Amministratore
    71 Thorntons Farm Avenue
    Rush Green
    RM7 0TS Romford
    Essex
    BritishDirector1887710001
    WALSH, James Michael
    St Elia
    Eaton Park
    KT11 2JF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    St Elia
    Eaton Park
    KT11 2JF Cobham
    Surrey
    AmericanCompany Director17400930002
    WEBB, David Royston
    13 Buckingham House
    Courtlands Sheen Road
    TW10 5AX Richmond
    Surrey
    Amministratore
    13 Buckingham House
    Courtlands Sheen Road
    TW10 5AX Richmond
    Surrey
    BritishLawyer11856310001
    WINDSOR, Paul
    Avenue Calas 11
    PO BOX 447, Ch-1211
    Geneva
    Ait Geneva Sa
    12
    Switzerland
    Amministratore
    Avenue Calas 11
    PO BOX 447, Ch-1211
    Geneva
    Ait Geneva Sa
    12
    Switzerland
    FranceBritishAccountant255377730001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr. Mohamed Al Fayed
    Park Lane
    W1K 1NA London
    60
    United Kingdom
    26 giu 2020
    Park Lane
    W1K 1NA London
    60
    United Kingdom
    Nazionalità: Egyptian
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Mr Mohamed Al Fayed
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    06 apr 2016
    55 Park Lane
    London
    W1K 1NA
    Nazionalità: Egyptian
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    30 ago 2023La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    HYDE PARK RESIDENCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of amendment and confirmation
    Creato il 23 dic 2009
    Consegnato il 24 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, the obligors and/or the bocardo obligor to the finance parties and/or the bocardo finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 24 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 lug 2008
    Consegnato il 12 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower or the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H office and basement premises st 55 park lane; unsold apartments 55 park lane and 14 south street london; 60 park lane fixed and floating charge over the undertaking and all assets including goodwill, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Postbank Ag
    Transazioni
    • 12 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creato il 22 apr 2005
    Consegnato il 30 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First legal mortgage the new property,first fixed charge all interests in the new property,all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures belonging to it),all other interests now and in the future over the new property or the proceeds of sale of the new property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transazioni
    • 30 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 03 mar 2005
    Consegnato il 17 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from prestige properties S.A., park lane residences limited and the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (1) l/h land being 55 park lane and 6 to 22 (even) south street, london W1 t/n LN42156, (2) l/h land being 14 south street, london W1 t/n LN156806, (3) l/h land being 56 to 62 (inclusive) park lane and 2 and 4 south street, london W1 t/n 453555, see form 395 for other properties charged;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 17 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture between prestige properties S.A.(the first chargor) park laned residences limited (the second chargor) the company (the third chargor) and bradford & bingley PLC
    Creato il 28 mar 2003
    Consegnato il 15 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 15 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creato il 24 giu 1999
    Consegnato il 05 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture dated 28TH january 1999
    Brevi particolari
    All right title estate and other interests of the company in the leasehold property k/a plots 203,204 and 220 (penthouse) harrods village barners london SW13 (to be k/a 57,58 and 60 william hunt mansions 4 somerville avenue london SW13 ) (the new security assets). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee and Agent for Each of the Beneficiaries
    Transazioni
    • 05 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 gen 1999
    Consegnato il 04 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from prestige properties sa to the chargee under the facility agreement (as defined) and/or under any hedging agreement (as defined) or the legal charge (as defined) and/or by the company to the chargee pursuant to the debenture on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 55-62 park lane and 2-22 south street london W1 and floating charge over the undertaking and all assets rights and income present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Trustee and Agent for Each of the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 04 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 09 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from prestige properties sa to the chargee under the facility agreement dated 27 july 1995,a legal charge dated 27 july 1995 and/or by the company to the chargee pursuant to the debenture (in each case as may be amended,varied or novated from time to time)
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all right title estate and other interests of the company in the l/h property k/as 55-62 park lane and 2-22 south street london W1 and/or the proceeds of sale thereof.floating charge all the undertaking and all the assets,rights and income of the company both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 ago 1989
    Consegnato il 25 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement of even date and this charge.
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the lease of 55 park lane and no's 6 to 22 (even numbers) and 14 south street 56 to 62 park lane and 2 and 4 south street london W1 and/or the proceeds of sale thereof. (Please see doc M395 for ful details).
    Persone aventi diritto
    • Prestige Properties Societe Anonyme
    Transazioni
    • 25 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 16 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0