HYDE PARK RESIDENCE LIMITED
Panoramica
Nome della società | HYDE PARK RESIDENCE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02061713 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 55 Park Lane London W1K 1NA |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
NAPLINK LIMITED | 06 ott 1986 | 06 ott 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 11 lug 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 25 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 11 lug 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2023 | 17 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Sebastian Amadeus Moritz come amministratore in data 15 apr 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo | 2 pagine | PSC08 | ||
Cessazione di Mohamed Al Fayed come persona con controllo significativo il 30 ago 2023 | 1 pagine | PSC07 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022 | 13 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021 | 19 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Paul Windsor come amministratore in data 16 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 26 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 26 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Notifica di Mohamed Al Fayed come persona con controllo significativo il 26 giu 2020 | 2 pagine | PSC01 | ||
Cessazione di Mohamed Al Fayed come persona con controllo significativo il 26 giu 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||
Nomina di Mr Andrew Spalton come amministratore in data 19 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 25 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Derek Alexander Picot come amministratore in data 01 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Astrid Bray come amministratore in data 31 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Paul Windsor come amministratore in data 07 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Mohamad Esreb come amministratore in data 15 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Andrew William Morgan come amministratore in data 31 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORITZ, Sebastian Amadeus | Amministratore | 20 St. Philips Ave KT4 8JT Worcester Park C/O Moricon Consultants Limited England | England | British | Consultant | 244740630001 | ||||
SPALTON, Andrew John | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | England | British | Accountant | 117413960002 | ||||
WATHEN-FAYED, Heini Jasmine | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | United Kingdom | Finnish | Director | 209518120001 | ||||
BAILY, Rosemary | Segretario | 179 Ashmore Road W9 3DB London | British | 35407110001 | ||||||
BROWN, Edgar Lewis | Segretario | 6 Malthouse Lane West End GU24 9JF Woking Surrey | British | 46031970001 | ||||||
CRAWFORD, Donald Stewart | Segretario | 20 Gloucester Road Tankerton CT5 2DF Whitstable Kent | British | Company Secretary | 34471810001 | |||||
DAVIES, James Ralph Parnell | Segretario | 24 Batchelors Way HP7 9AJ Amersham Buckinghamshire | British | 47335710002 | ||||||
MORGAN, Andrew William | Segretario | 55 Park Lane London W1K 1NA | British | 72348270001 | ||||||
PROSSER, Howell Granville | Segretario | 90 Peregrine Road TW16 6JP Sunbury On Thames Middlesex | British | 38837860001 | ||||||
BOZEK, Alison Jane | Amministratore | 26 Sarre Road NW2 3SL London | British | Company Director | 45991620001 | |||||
BOZEK, Alison Jane | Amministratore | 26 Sarre Road NW2 3SL London | British | Secretary | 45991620001 | |||||
BRAY, Astrid | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | England | British | General Manager/Managing Director | 205745880001 | ||||
CRAWFORD, Donald Stewart | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | England | British | Accountant | 34471810001 | ||||
DAVIS, Ronald Ashley Blandford | Amministratore | 160 Straight Road Old Windsor SL4 2SG Windsor Berkshire | British | Development Manager | 44739840001 | |||||
ESREB, Mohamad | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | United Kingdom | British | Bachelor Of Engineering | 187382940001 | ||||
FALLOWFIELD, Robert James | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | England | British | Accountant | 24469760001 | ||||
HOGBEN, Norman Muirhead | Amministratore | Willow Hayne 46 Chantry View Road GU1 3XT Guildford Surrey | British | Director | 254030001 | |||||
KLEIN, Franz Josef | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | France | German | Hotelier | 18310070001 | ||||
MERRICK, Ian | Amministratore | Beechcroft 53 Sidney Road KT12 2LZ Walton On Thames Surrey | British | General Manager | 74904320001 | |||||
MORGAN, Andrew William | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | England | British | Accountant | 72348270001 | ||||
PICOT, Derek Alexander | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | United Kingdom | British | Non Executive Director | 89605760003 | ||||
ROONEY, Tim Patrick | Amministratore | 57 Torbay Road NW6 7DU London | British | General Manager | 18268570001 | |||||
THOMAS, Francois | Amministratore | 55 Park Lane London W1K 1NA | United Kingdom | French | Director | 160143400001 | ||||
TILLMAN, John | Amministratore | 71 Thorntons Farm Avenue Rush Green RM7 0TS Romford Essex | British | Director | 1887710001 | |||||
WALSH, James Michael | Amministratore | St Elia Eaton Park KT11 2JF Cobham Surrey | American | Company Director | 17400930002 | |||||
WEBB, David Royston | Amministratore | 13 Buckingham House Courtlands Sheen Road TW10 5AX Richmond Surrey | British | Lawyer | 11856310001 | |||||
WINDSOR, Paul | Amministratore | Avenue Calas 11 PO BOX 447, Ch-1211 Geneva Ait Geneva Sa 12 Switzerland | France | British | Accountant | 255377730001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr. Mohamed Al Fayed | 26 giu 2020 | Park Lane W1K 1NA London 60 United Kingdom | Sì |
Nazionalità: Egyptian Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
Mr Mohamed Al Fayed | 06 apr 2016 | 55 Park Lane London W1K 1NA | Sì |
Nazionalità: Egyptian Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per HYDE PARK RESIDENCE LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
30 ago 2023 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
HYDE PARK RESIDENCE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment and confirmation | Creato il 23 dic 2009 Consegnato il 24 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company, the obligors and/or the bocardo obligor to the finance parties and/or the bocardo finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 02 lug 2008 Consegnato il 12 lug 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the borrower or the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H office and basement premises st 55 park lane; unsold apartments 55 park lane and 14 south street london; 60 park lane fixed and floating charge over the undertaking and all assets including goodwill, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 22 apr 2005 Consegnato il 30 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari First legal mortgage the new property,first fixed charge all interests in the new property,all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures belonging to it),all other interests now and in the future over the new property or the proceeds of sale of the new property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed | Creato il 03 mar 2005 Consegnato il 17 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from prestige properties S.A., park lane residences limited and the company to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari (1) l/h land being 55 park lane and 6 to 22 (even) south street, london W1 t/n LN42156, (2) l/h land being 14 south street, london W1 t/n LN156806, (3) l/h land being 56 to 62 (inclusive) park lane and 2 and 4 south street, london W1 t/n 453555, see form 395 for other properties charged;. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture between prestige properties S.A.(the first chargor) park laned residences limited (the second chargor) the company (the third chargor) and bradford & bingley PLC | Creato il 28 mar 2003 Consegnato il 15 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 24 giu 1999 Consegnato il 05 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a debenture dated 28TH january 1999 | |
Brevi particolari All right title estate and other interests of the company in the leasehold property k/a plots 203,204 and 220 (penthouse) harrods village barners london SW13 (to be k/a 57,58 and 60 william hunt mansions 4 somerville avenue london SW13 ) (the new security assets). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 gen 1999 Consegnato il 04 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies obligations and liabilities due or to become due from prestige properties sa to the chargee under the facility agreement (as defined) and/or under any hedging agreement (as defined) or the legal charge (as defined) and/or by the company to the chargee pursuant to the debenture on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 55-62 park lane and 2-22 south street london W1 and floating charge over the undertaking and all assets rights and income present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 31 lug 1995 Consegnato il 09 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from prestige properties sa to the chargee under the facility agreement dated 27 july 1995,a legal charge dated 27 july 1995 and/or by the company to the chargee pursuant to the debenture (in each case as may be amended,varied or novated from time to time) | |
Brevi particolari By way of legal mortgage all right title estate and other interests of the company in the l/h property k/as 55-62 park lane and 2-22 south street london W1 and/or the proceeds of sale thereof.floating charge all the undertaking and all the assets,rights and income of the company both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 24 ago 1989 Consegnato il 25 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement of even date and this charge. | |
Brevi particolari By way of legal mortgage the lease of 55 park lane and no's 6 to 22 (even numbers) and 14 south street 56 to 62 park lane and 2 and 4 south street london W1 and/or the proceeds of sale thereof. (Please see doc M395 for ful details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0