CENTRE DESIGN LIMITED

CENTRE DESIGN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCENTRE DESIGN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02064325
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CENTRE DESIGN LIMITED?

    • Creazione artistica (90030) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova CENTRE DESIGN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tynecastle House,
    Low Prudhoe,
    NE42 6NP Northumberland.
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CENTRE DESIGN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE MASON KERR PARTNERSHIP LIMITED13 ago 198713 ago 1987
    BATHSTREAM LIMITED14 ott 198614 ott 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di CENTRE DESIGN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CENTRE DESIGN LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CENTRE DESIGN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2013

    Stato del capitale al 01 lug 2013

    • Capitale: GBP 47,100
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 gen 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 gen 2011

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Jeffrey William Berry come amministratore

    2 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    21 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    5 pagineMG01

    Cessazione della carica di Christopher Barratt come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Conflict of interest 05/10/2010
    RES13
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 07 dic 2010

    • Capitale: GBP 47,100
    4 pagineSH06

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 gen 2010

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 gen 2009

    18 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio per una società di medie dimensioni redatto al 31 gen 2008

    19 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di CENTRE DESIGN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MASON, Peter Russell Fenwick
    Pine Grove
    M30 9JL Monton Eccles
    24
    Manchester
    Segretario
    Pine Grove
    M30 9JL Monton Eccles
    24
    Manchester
    BritishCo Director82370480003
    BERRY, Jeffrey William
    Stoke Park Road
    Stoke Bishop
    BS9 1SF Bristol
    23
    Bristol
    United Kingdom
    Amministratore
    Stoke Park Road
    Stoke Bishop
    BS9 1SF Bristol
    23
    Bristol
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant122228810002
    MASON, Peter Russell Fenwick
    Pine Grove
    M30 9JL Monton Eccles
    24
    Manchester
    Amministratore
    Pine Grove
    M30 9JL Monton Eccles
    24
    Manchester
    United KingdomBritishCompany Director82370480003
    ALLISON, Graeme
    34 Broadlands
    Cleadon
    SR6 7RD Sunderland
    Tyne & Wear
    Segretario
    34 Broadlands
    Cleadon
    SR6 7RD Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishAccountant87657890002
    MASON, Peter
    Birkenside Farm House
    DH8 9LU Shotley Field
    County Durham
    Segretario
    Birkenside Farm House
    DH8 9LU Shotley Field
    County Durham
    BritishCompany Director82370480001
    ALLISON, Graeme
    16 Roundstone Close
    Haydon Grange
    NE7 7GH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    16 Roundstone Close
    Haydon Grange
    NE7 7GH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishAccountant87657890001
    BARRATT, Christopher John
    14 Gorwell
    OX49 5QE Watlington
    Oxfordshire
    Amministratore
    14 Gorwell
    OX49 5QE Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritishAccountant67075250005
    EVERETT, Louise Mary
    94 Penwortham Road
    Streatham
    SW16 6RJ London
    Amministratore
    94 Penwortham Road
    Streatham
    SW16 6RJ London
    BritishSales Director97545890001
    HUME, Richard David
    15 Middridge Road
    Langley Park
    DH7 9FH Durham
    County Durham
    Amministratore
    15 Middridge Road
    Langley Park
    DH7 9FH Durham
    County Durham
    BritishDesign Director87890130001
    KERR, Iain Stuart
    Brackenrigg
    33 Batt House Road
    NE43 7RA Stocksfield
    Northumberland
    Amministratore
    Brackenrigg
    33 Batt House Road
    NE43 7RA Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritishCompany Director112958610001
    PATRICK, Peter Caldwell
    The Crescent
    Dunston
    NE11 9SJ Gateshead
    4
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    The Crescent
    Dunston
    NE11 9SJ Gateshead
    4
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant147568670001
    WALKER, Alexander Macbean
    Lednabra
    G63 0NG Balfron Station
    Stirlingshire
    Amministratore
    Lednabra
    G63 0NG Balfron Station
    Stirlingshire
    BritishConsultant54911900001
    MENTOR UK LIMITED
    Millwheel Cottage
    Sandford Lane, Woodley
    RG5 4TB Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Millwheel Cottage
    Sandford Lane, Woodley
    RG5 4TB Reading
    Berkshire
    86920230001

    CENTRE DESIGN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 dic 2010
    Consegnato il 06 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of properties charged please refer to form MG01) all properties, all rights, licences, guarantees, rents, deposits, contracts, covenants and warranties, goodwill and uncalled capital, all equipment and by way of floating charge all the undertaking property, assets and rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Caroline Mary Smallwood and the Trustees of the Trevor Smallwood Settlement
    Transazioni
    • 06 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2004
    Consegnato il 20 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,205,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Downing Classic Vct 2 PLC and Downing Classic Vct 3 PLC
    Transazioni
    • 20 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 giu 2003
    Consegnato il 19 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 giu 2003
    Consegnato il 19 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property tynecastle house, prudhoe, northumberland t/n ND66252. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 giu 2000
    Consegnato il 20 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 06 apr 1993
    Consegnato il 14 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £27796.70 due from the company to the chargee under the agreement
    Brevi particolari
    All its right title and interest payable under the insurances.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 14 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 1990
    Consegnato il 04 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Tynecastle house, station bank, prudhoe northumberland fixed and.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC.
    Transazioni
    • 04 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mag 1988
    Consegnato il 20 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0