ONE POST LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ONE POST LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02068605 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ONE POST LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ONE POST LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Deluxe House Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South UB6 7RH Perivale England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ONE POST LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SOHO 601 DIGITAL PRODUCTIONS LIMITED | 09 apr 1987 | 09 apr 1987 |
| DEAN STREET DIGITAL PRODUCTIONS LIMITED | 08 dic 1986 | 08 dic 1986 |
| CHARCO ONE HUNDRED AND TWELVE LIMITED | 29 ott 1986 | 29 ott 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ONE POST LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per ONE POST LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Deluxe Limited Film House 142 Wardour Street London W1F 8DD England a Deluxe House Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South Perivale UB6 7RH in data 29 gen 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Deluxe House Unit 32, Perivale Business Park Perivale UB6 7RH | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Eric Cummins come amministratore in data 30 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 9 pagine | MA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo | 2 pagine | PSC08 | ||||||||||
Cessazione di Ronald Owen Perelman come persona con controllo significativo il 06 nov 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Michael Bell come amministratore in data 18 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ralph Abraham Levy come amministratore in data 18 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sirmad Balal Shafique come amministratore in data 18 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Stefanie Liquori Digrigoli come amministratore in data 17 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Roger Stuart Howl come amministratore in data 07 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ralph Abraham Levy come amministratore in data 07 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sirmad Balal Shafique come amministratore in data 07 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Michael Bell come amministratore in data 07 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Eric Cummins come amministratore in data 01 mag 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ONE POST LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUORI DIGRIGOLI, Stefanie | Amministratore | Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South UB6 7RH Perivale Deluxe House England | United States | American | 262502870001 | |||||
| BURNETT, Robert Kenneth | Segretario | Flat 5 86 Addison Road W14 8ED London | British | 23134210001 | ||||||
| BURNETT, Robert Kenneth | Segretario | Flat 5 86 Addison Road W14 8ED London | British | 23134210001 | ||||||
| CATTERALL, Christopher Edward | Segretario | 137-144 High Holborn WC1V 6PL London Holborn Tower England | 169542710001 | |||||||
| CLEARY, David James | Segretario | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | 217500460001 | |||||||
| CREEDON, Michael John | Segretario | 503 Oundle Road Orton Longueville PE2 7DQ Peterborough Cambridgeshire | British | 71649190001 | ||||||
| DEWAR, Gordon Duthie | Segretario | 19 Gilpin Avenue SW14 8QX London | British | 50726160001 | ||||||
| EASTMAN, Emma Nicole | Segretario | Flat 3 111 Clarendon Road W11 4JG London | British | 76154110001 | ||||||
| HEWITT, Mark Andrew | Segretario | 104a Queens Drive Finsbury Park N4 2HW London | British | 34542120001 | ||||||
| PAINE, Nicholas | Segretario | 47 Chaucer Road RG45 7QN Crowthorne Berks | British | 32418620002 | ||||||
| PIZEY, Simon Peter Douglas Frank | Segretario | 5 Riverside Tower Imperial Wharf SW6 2SW London | British | 112543720001 | ||||||
| WATSON, James Neil | Segretario | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | 194251550001 | |||||||
| WATSON, James Neil | Segretario | 142 Wardour Street W1F 8DD London Film House England | British | 71254060003 | ||||||
| ADAMS, Matthew James | Amministratore | 8 Waterloo Road MK40 3PQ Bedford Bedfordshire | British | 69632180001 | ||||||
| ADAMS, Raymond Dennis | Amministratore | 14 Sefton Paddock Stoke Poges SL2 4PT Slough Berkshire | British | 9941480001 | ||||||
| ANWAR, Des | Amministratore | 32 Elaine Grove Gospel Oak NW5 4QH London | British | 59932880001 | ||||||
| BELL, Andrew Michael | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | England | British | 117165060003 | |||||
| BROWN, Gary Jonathon | Amministratore | 40a Aliwal Road SW11 1RD London | British | 59837660001 | ||||||
| BURNETT, Robert Kenneth | Amministratore | Flat 5 86 Addison Road W14 8ED London | United Kingdom | British | 23134210001 | |||||
| BURNETT, Robert Kenneth | Amministratore | Flat 5 86 Addison Road W14 8ED London | United Kingdom | British | 23134210001 | |||||
| BYGRAVE, James Richard Derek Eng-Ho | Amministratore | Upper 5 Lydon Road Clapham SW4 0HP London | British | 37152460001 | ||||||
| CAPPER, Jocelin Rachel | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United Kingdom | British | 107791730001 | |||||
| CLARKE, Nicholas | Amministratore | The Old Manor House Church Road Buckworth PE28 5AL Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 35102020002 | |||||
| CREEDON, Michael John | Amministratore | 503 Oundle Road Orton Longueville PE2 7DQ Peterborough Cambridgeshire | British | 71649190001 | ||||||
| CUMMINS, John Eric | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 246542580001 | |||||
| DAVIDSON, Neil Patrick | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | Usa | American | 197003660001 | |||||
| DEWAR, Gordon Duthie | Amministratore | 19 Gilpin Avenue SW14 8QX London | British | 50726160001 | ||||||
| DOWNING, Terry William | Amministratore | 52 Streathbourne Road SW17 8QX London | United Kingdom | British | 109287950001 | |||||
| GURNEY, Patrick Philip | Amministratore | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | England | British | 216332150001 | |||||
| HANCOCK, Bruce Geoffrey | Amministratore | 19 Earlham House 35 Mercer Street WC2H 9QS London | Australian | 61092690001 | ||||||
| HEWITT, Mark Andrew | Amministratore | 104a Queens Drive Finsbury Park N4 2HW London | United Kingdom | British | 34542120001 | |||||
| HOWL, Roger Stuart | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | England | British | 199288360001 | |||||
| HUSAIN, Saleem | Amministratore | 60 Raleigh Drive N20 0UU London | England | British | 21881910002 | |||||
| JACOMB, Thomas Richard | Amministratore | Malt House Main Street, Chilton OX11 0RZ Didcot Oxfordshire | British | 64348500001 | ||||||
| JULIAN, Robert Keith | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 238211530001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ONE POST LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Ronald Owen Perelman | 06 mag 2016 | 35 East 62nd Street NY 10065 New York Macandrews & Forbes Building Manhatten Usa | Sì |
Nazionalità: American Paese di residenza: United States | |||
Natura del controllo
| |||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per ONE POST LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 06 nov 2019 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
ONE POST LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 06 set 1996 Consegnato il 19 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 gen 1992 Consegnato il 28 gen 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade and tenant's fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0