INTERBRAND GROUP
Panoramica
Nome della società | INTERBRAND GROUP |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
Numero di società | 02071702 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INTERBRAND GROUP?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova INTERBRAND GROUP?
Indirizzo della sede legale | Bankside 3 90 - 100 Southwark Street SE1 0SW London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INTERBRAND GROUP?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BULKBONUS PUBLIC LIMITED COMPANY | 06 nov 1986 | 06 nov 1986 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INTERBRAND GROUP?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per INTERBRAND GROUP?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 07 lug 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 21 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 07 lug 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per INTERBRAND GROUP?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cessazione della carica di David Lee Bachmann come amministratore in data 01 apr 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2023 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 6 pagine | AA | ||
Nomina di Mr John Martin William Betts come amministratore in data 13 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 6 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 7 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Michael Payne il 16 dic 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Georgina Ann Love il 16 dic 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Nomina di Mr David Lee Bachmann come amministratore in data 31 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Mark Anthony O'brien come amministratore in data 31 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 lug 2019 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Das Europe Limited come persona con controllo significativo il 20 dic 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 7 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Mark Anthony O'brien come amministratore in data 31 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Peter Douglas Trueman come amministratore in data 31 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mrs Georgina Ann Love come amministratore in data 31 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Andrew Michael Payne come amministratore in data 01 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Sally Ann Bray il 03 set 2018 | 1 pagine | CH03 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Bankside 3 90-100 Southwark Street London SE1 0SW England a Bankside 3 90 - 100 Southwark Street London SE1 0SW in data 05 set 2018 | 1 pagine | AD01 | ||
Chi sono gli amministratori di INTERBRAND GROUP?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAY, Sally Ann | Segretario | 90-100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 3 England | British | 51704000002 | ||||||
BETTS, John Martin William | Amministratore | Level 1, 100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 2 England | England | British | Legal Counsel | 251270030001 | ||||
LOVE, Georgina Ann | Amministratore | 90 - 100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 2 England | England | British | Global Chief Talent Officer | 252552090001 | ||||
PAYNE, Andrew Michael | Amministratore | 90 - 100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 2 England | England | British | Creative Director | 70586170002 | ||||
JOHNSON, Lorraine Jeanette | Segretario | Tugwood Kings Lane SL6 9TZ Cookham Dean Berkshire | British | 1529610003 | ||||||
WOOLLEY, Diana Rosemary | Segretario | Humphries Bar Naunton GL54 3AS Cheltenham Gloucestershire | British | 66518590002 | ||||||
ALLEN, Anthony Michael | Amministratore | 3 Kingsley Mews W8 5PY London | England | British | Company Director | 29822810004 | ||||
ALLERT, John Maxwell | Amministratore | Squirrels Fairmile Park Road KT11 2PG Cobham Surrey | Australian | Chief Operating Officer | 99264370001 | |||||
BACHMANN, David Lee | Amministratore | Broadway 18th Floor 10007 New York 195 United States | United States | American | Cfo Interbrand & Omnicom Branding Group | 263958710001 | ||||
BATCHELOR, Alexander William | Amministratore | 12 Hayward Road KT7 0BE Thames Ditton Surrey | England | British | Director | 55351800003 | ||||
BIRKIN, Michael John | Amministratore | Ferry Barn Smugglers Lane, Bosham PO18 8QW Chichester West Sussex | British | Director | 23500200005 | |||||
BLACKETT, Thomas Richard | Amministratore | Wallsend Elmstead Road KT14 6JB West Byfleet Surrey | British | Director | 32502030002 | |||||
BRYMER, Charles Edward | Amministratore | 35 Lakewood Circle North CT06830 Greenwich United States | Us Citizen | Director | 55215970002 | |||||
CARPENTER, Donald Lee | Amministratore | 2200 Deep Hollow Lane Dayton Ohio 45419 | Us Citizen | Ceo Design Forum | 81922110001 | |||||
CLIFTON, Rita Ann | Amministratore | Woodend Farmhouse Woodend SL7 2HW Medmenham Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 150443010001 | ||||
COULDERY, Susan Jane | Amministratore | 6 Copthall Gardens TW1 4HJ Twickenham Middlesex | British | Chartered Accountant | 28823750004 | |||||
DANET, Jean Baptiste | Amministratore | 5 Boulevard Inkermann 92200 Neuilly France | French | Director | 99491150001 | |||||
FAULKNER, Kim | Amministratore | 100 University Road FOREIGN Singapore 297904 Singapore | Singapore | Director | 73881500001 | |||||
FOGG, Janet Diane | Amministratore | 57 Noel Road Islington N1 8HE London | England | British | Trade Mark Agent | 84329330002 | ||||
FRAMPTON, Jeremy John | Amministratore | 1 Sutherland Avenue BR5 1QX Petts Wood Kent | United Kingdom | British | Director | 60799880002 | ||||
GALL, Kelly Ann | Amministratore | Strand WC2R 0DW London 85 United Kingdom | United States | American | Cfo/Coo | 154937500001 | ||||
GERSTMAN, Richard | Amministratore | 15 Park Street 07670 Tenafly New Jersey Usa | American | Company Director | 50038610001 | |||||
HAEUSLER, Juergen, Dr | Amministratore | Hofackerstrasse 46 FOREIGN Zurich 8032 Switzerland | German | Ceo Of Interbrand Zintmeyer & | 76961580002 | |||||
HEARLEY, Timothy Michael | Amministratore | Rush Leys 4 Birds Hill Rise Oxshott KT22 0SW Leatherhead Surrey | England | British | Director | 47903210001 | ||||
LONEY, Suzanne Christina Rosemarie | Amministratore | 239 Old Marylebone Road London NW1 5QT | Scotland | British | Chief Financial Officer | 52276860002 | ||||
MARTIN, David | Amministratore | Apt 15n 400 East 57th Street New York Ny 10022 United States | Us Citizen | Executive Director | 79529870001 | |||||
MCNALLY, Richard | Amministratore | 2 Walton Court Dix Hills New York Ny 11746 FOREIGN Usa | American | Company Director | 55216050001 | |||||
MILLS, Iain C | Amministratore | Home Farm Hurley Common Atherstone CV9 2LR Warwick | British | Member Of Parliament | 32502050001 | |||||
MURPHY, John Matthew | Amministratore | The Grange Brockdish IP21 4JE Diss Norfolk | British | Director | 67032160001 | |||||
O'BRIEN, Mark Anthony | Amministratore | Broadway NY 10007 New York City 195 United States | United States | American | Director | 270957510001 | ||||
OLIVER, Terence | Amministratore | C/O 3rd Izumiya Bldg 1-1 Kojimachi 3-Chome Chiyoda-Ku Tokyo 102 Japan | British | Director | 11170150001 | |||||
ORSINI, James Lawrence | Amministratore | 15 Aspen Drive Livingstone New Jersey 07039 United States | Us Citizen | Accountant | 72789000001 | |||||
PENROSE, Noel Richard | Amministratore | Strand WC2R 0DW London 85 United Kingdom | England | British | Group Commercial Director | 41781310002 | ||||
PENROSE, Noel Richard | Amministratore | Dunvegan House The Street Shurlock Row RG10 0PR Reading Berkshire | England | British | Group Commercial Dir | 41781310002 | ||||
PENROSE, Noel Richard | Amministratore | Dunvegan House The Street Shurlock Row RG10 0PR Reading Berkshire | England | British | Director | 41781310002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di INTERBRAND GROUP?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das Europe Limited | 06 apr 2016 | 90-100 Southwark Street SE1 0SW London Bankside 3 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
INTERBRAND GROUP ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Transfer deed | Creato il 09 ago 1993 Consegnato il 25 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 10 lug 1989 Consegnato il 11 lug 1989 | In corso | Importo garantito For securing the rent and the insurance rent payable by the company to the chargee under the terms of a lease dated 25.10.89 | |
Brevi particolari The sum of £211,800 deposited by the chargor in an account with hill samuel bank limited in the joint names of the chargor and the chargee and all sums withdrawn therefrom. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 02 feb 1989 Consegnato il 09 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. All book & other debts plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 mar 1987 Consegnato il 07 apr 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 mar 1987 Consegnato il 18 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0