THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED

THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02072621
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 64 Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Essex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    YIELDSTAKE LIMITED11 nov 198611 nov 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE a Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE in data 07 dic 2015

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Sally Ann Coughlan il 28 set 2014

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ott 2014

    Stato del capitale al 06 ott 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Queens Court, 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG a 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE in data 29 set 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Martin Quinn come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Matthew Rosenberg come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 nov 2013

    Stato del capitale al 19 nov 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Erwin Rieck come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di W2001 Two Cv come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di W2001 Britannia Llc come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2011

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Erwin Joseph Rieck il 12 set 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 set 2010

    6 pagineAR01

    Nomina di W2001 Britannia Llc come amministratore

    2 pagineAP02

    Nomina di W2001 Two Cv come amministratore

    2 pagineAP02

    Cessazione della carica di Veronique Menard come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COUGHLAN, Sally Ann
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    Segretario
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    British107832420001
    QUINN, Martin Joseph
    34 Francis Grove
    Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    Amministratore
    34 Francis Grove
    Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    EnglandIrish186571310001
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    Segretario
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    Segretario
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Segretario
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Segretario
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    STADEN, Paul Sidney
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    Segretario
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    British35453800001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    Segretario
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    Amministratore
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    British101912850001
    ASHFORD, Martin John
    The Elms
    Chessetts Wood Road
    B94 6EL Lapworth
    Solihull
    Amministratore
    The Elms
    Chessetts Wood Road
    B94 6EL Lapworth
    Solihull
    British1450190001
    COLES, Alan Clifford
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    EnglandBritish101144900002
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Amministratore
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Canadian101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    Amministratore
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritish14330100002
    CUTTS, John Charles
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish56651680001
    GOIN, Russell Todd
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    Amministratore
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    American108675490001
    KABALAN, Fadi
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    Amministratore
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    EnglandBritish133846470001
    KRAIS, Ashley Simon
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    Amministratore
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    United KingdomBritish105921220001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish4958800007
    MENARD, Veronique Pascale Dominique
    Messina Avenue
    NW6 4LD London
    8
    Amministratore
    Messina Avenue
    NW6 4LD London
    8
    United KingdomFrench141156250001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40294180002
    MOORE, Richard John
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    Amministratore
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    EnglandBritish101144680001
    MULAHASANI, Heather Louise
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    Amministratore
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    EnglandBritish136994090001
    OGDEN, Kathryn
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    Amministratore
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    American114248790002
    RIECK, Erwin Joseph
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Amministratore
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    German108675520002
    ROSENBERG, Matthew Alexander
    Coppice Walk
    Totteridge
    N20 8BZ London
    12
    Amministratore
    Coppice Walk
    Totteridge
    N20 8BZ London
    12
    EnglandBritish134723670001
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish83743120001
    STADEN, Paul Sidney
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    Amministratore
    Swallows Barn
    New College Court
    MK18 5JP Chackmore
    Buckingham
    British35453800001
    W2001 BRITANNIA LLC
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    Amministratore
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    Forma giuridicaLIMITED LIABILITY COMPANY
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleDELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY ACT
    152068480001
    W2001 TWO CV
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    Amministratore
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione34207195
    152068240001

    THE MIDLAND PROPERTY COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 23 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 24 nov 2004
    Consegnato il 14 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transazioni
    • 14 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 giu 2004
    Consegnato il 25 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    Transazioni
    • 25 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    Creato il 08 giu 2004
    Consegnato il 11 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transazioni
    • 11 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 mar 2004
    Consegnato il 26 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    Transazioni
    • 26 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 mag 1992
    Consegnato il 04 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or ashford construction limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north west of newport pagnell road,hardingstone, northampton,northamptonshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 mag 1991
    Consegnato il 04 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or ashford construction limited to the chargee on any account whatsover.
    Brevi particolari
    Land on north west of newport pagnell road hardingstone, northampton northamptonshire title no:- nn 133053.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 ago 1989
    Consegnato il 08 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or m j ashford & co. Limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    1.3 acres of f/h land at london road, northampton, northamptonshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0