LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED

LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02076615
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED?

    • Attività di società holding di produzione (64202) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LLOYD LOOM FURNITURE LIMITED19 apr 198919 apr 1989
    LLOYD LOOM CHAIRS LIMITED24 nov 198624 nov 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    10 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 feb 2017

    11 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Alexander Lawson Jacobs 1 Kings Avenue London N21 3NA England a 1 Kings Avenue Winchmore Hill London N21 3NA in data 04 mar 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 17 feb 2016

    LRESEX

    Cessazione della carica di Yun Chen come amministratore in data 01 dic 2015

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Lloyd Loom 71 to 75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ United Kingdom a C/O Alexander Lawson Jacobs 1 Kings Avenue London N21 3NA in data 03 feb 2016

    1 pagineAD01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Indirizzo della sede legale modificato da 71 to 75 Shelton Street 71 to 75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ United Kingdom a C/O Lloyd Loom 71 to 75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ in data 22 gen 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2014

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Wardentree Lane, Pinchbeck Spalding Lincolnshire PE11 3UG a 71 to 75 Shelton Street 71 to 75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ in data 19 gen 2016

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2015 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 22 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 feb 2015

    Stato del capitale al 03 feb 2015

    • Capitale: GBP 427,847.4
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2013

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Janet Mountain come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Janet Mountain come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Ms Yun Chen come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 22 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 ago 2013

    Stato del capitale al 22 ago 2013

    • Capitale: GBP 378,095
    SH01

    Chi sono gli amministratori di LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DRAXLER, Anthony Brian
    Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    1
    Amministratore
    Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    1
    EnglandEnglishManaging Director180541780001
    ATTERBY, John Robert
    Ickleford House
    86 Carlton Road
    PE21 8PQ Boston
    Lincolnshire
    Segretario
    Ickleford House
    86 Carlton Road
    PE21 8PQ Boston
    Lincolnshire
    BritishAccountant28033630001
    BANYARD, Layla
    8 Barley Lane
    LN4 4GW Billinghay
    Lincolnshire
    Segretario
    8 Barley Lane
    LN4 4GW Billinghay
    Lincolnshire
    BritishAccountant92802540002
    MOUNTAIN, Janet Mary
    Abbey Bungalow Baythorpe
    Swineshead
    PE20 3EY Boston
    Lincolnshire
    Segretario
    Abbey Bungalow Baythorpe
    Swineshead
    PE20 3EY Boston
    Lincolnshire
    BritishAccountant10838990001
    ROBERTSON, Peter Thomson
    The Manor Farm
    LN11 8QS South Ormsby
    Lincolnshire
    Segretario
    The Manor Farm
    LN11 8QS South Ormsby
    Lincolnshire
    ScottishDirector67594980003
    SKINNER, Harry John
    Chesscroft
    Chenies Village
    WD3 6EB Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    Chesscroft
    Chenies Village
    WD3 6EB Rickmansworth
    Hertfordshire
    British23168190001
    STANBRIDGE, Raymond John, Dr
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Nettleham
    LN2 2RH Lincoln
    Lincolnshire
    Segretario
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Nettleham
    LN2 2RH Lincoln
    Lincolnshire
    British52596640001
    WEBB, David
    11 The Parkway
    PE11 3EE Spalding
    Lincolnshire
    Segretario
    11 The Parkway
    PE11 3EE Spalding
    Lincolnshire
    British41730630001
    ATTERBY, John Robert
    Ickleford House
    86 Carlton Road
    PE21 8PQ Boston
    Lincolnshire
    Amministratore
    Ickleford House
    86 Carlton Road
    PE21 8PQ Boston
    Lincolnshire
    BritishAccountant28033630001
    BREESE, David Jonathan James
    Menominee Churchgate
    Gedney
    PE12 0BZ Spalding
    Lincolnshire
    Amministratore
    Menominee Churchgate
    Gedney
    PE12 0BZ Spalding
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director41718070003
    BREESE, Kim
    Sycamore Cottage Green Lane
    Donington Wykes
    PE11 4SL Spalding
    Lincolnshire
    Amministratore
    Sycamore Cottage Green Lane
    Donington Wykes
    PE11 4SL Spalding
    Lincolnshire
    BritishCompany Director12840820001
    BROWNE, Tony Allan
    Wardentree Lane, Pinchbeck
    Spalding
    PE11 3UG Lincolnshire
    Amministratore
    Wardentree Lane, Pinchbeck
    Spalding
    PE11 3UG Lincolnshire
    EnglandBritishSales Director177223330001
    BROWNE, Tony Alan
    51 Chelsea Road
    Fairford Leys
    HP19 7BG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    51 Chelsea Road
    Fairford Leys
    HP19 7BG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishSales Director110040150001
    CHEN, Yun
    c/o Alexander Lawson Jacobs
    Kings Avenue
    N21 3NA London
    1
    England
    Amministratore
    c/o Alexander Lawson Jacobs
    Kings Avenue
    N21 3NA London
    1
    England
    EnglandBritishDirector167088290001
    DAVENPORT, Elizabeth Julie
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    United KingdomBritishNone16007640002
    DAVENPORT, Elizabeth Julie
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector16007640002
    DAVENPORT, Michael Christopher
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    Court Farm House
    Letcombe Bassett
    OX12 9LR Wantage
    Oxfordshire
    BritishDirector393470002
    DUNCOMBE, Stephanie Linda
    Field Cottage
    Eccles On Sea
    NR12 0SW Norwich
    Amministratore
    Field Cottage
    Eccles On Sea
    NR12 0SW Norwich
    EnglandBritishDirector116400370002
    EDWARDS, Brian John
    Wardentree Lane, Pinchbeck
    Spalding
    PE11 3UG Lincolnshire
    Amministratore
    Wardentree Lane, Pinchbeck
    Spalding
    PE11 3UG Lincolnshire
    United KingdomBritishManaging Director123102650003
    GARTH, Martin Stuart
    Wardentree Lane, Pinchbeck
    Spalding
    PE11 3UG Lincolnshire
    Amministratore
    Wardentree Lane, Pinchbeck
    Spalding
    PE11 3UG Lincolnshire
    United KingdomBritishCommercial Director116025580001
    HORNE, Kenneth Ellison
    Weldon House Vyse Road
    Boughton
    NN2 8RP Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Weldon House Vyse Road
    Boughton
    NN2 8RP Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director12840800001
    MOUNTAIN, Janet Mary
    Abbey Bungalow Baythorpe
    Swineshead
    PE20 3EY Boston
    Lincolnshire
    Amministratore
    Abbey Bungalow Baythorpe
    Swineshead
    PE20 3EY Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritishFinance Director10838990001
    SKINNER, Harry John
    Chesscroft
    Chenies Village
    WD3 6EB Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Chesscroft
    Chenies Village
    WD3 6EB Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishSolicitor23168190001
    SKINNER, Joyce Jane Florence
    Chesscroft
    Chenies
    WD3 6EB Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Chesscroft
    Chenies
    WD3 6EB Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishNone61699910001
    STANBRIDGE, Raymond John, Dr
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Nettleham
    LN2 2RH Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Nettleham
    LN2 2RH Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritishCompany Director52596640001
    WALKER, Michael James
    Field Cottage
    Eccles On Sea
    NR12 0SW Norwich
    Amministratore
    Field Cottage
    Eccles On Sea
    NR12 0SW Norwich
    EnglandBritishManaging Director68283400004

    LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed
    Creato il 21 mar 2007
    Consegnato il 03 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £6,875 and any other sums paid into the account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Grosvenor Estate Belgravia
    Transazioni
    • 03 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Third debenture
    Creato il 08 set 2006
    Consegnato il 16 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £140,000.Oo and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Greyfriars Investments Limited
    Transazioni
    • 16 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second debenture
    Creato il 08 set 2006
    Consegnato il 16 set 2006
    In corso
    Importo garantito
    £162,000.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael Christopher Davenport and Elizabeth Julie Davenport
    Transazioni
    • 16 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Single debenture
    Creato il 22 set 1992
    Consegnato il 25 set 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 09 gen 1991
    Consegnato il 19 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the goodwill undertaking and all property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Greyfriars Investments LTD
    Transazioni
    • 19 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 nov 1990
    Consegnato il 22 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 1989
    Consegnato il 15 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • United Pensions and Estate Trustees Limited
    • J M Vitoria
    • E E T Vitoria
    Transazioni
    • 15 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 28 feb 1989
    Consegnato il 06 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1989Registrazione di un'ipoteca

    LLOYD LOOM OF SPALDING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 feb 2016Inizio della liquidazione
    28 set 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ninos Koumettou
    Alexander Lawson Jacobs
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London
    Praticante
    Alexander Lawson Jacobs
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0