KESWICK HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | KESWICK HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02078966 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KESWICK HOLDINGS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova KESWICK HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 43-45 Portman Square W1H 6LY London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di KESWICK HOLDINGS LIMITED?
| Scaduto | Sì |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2016 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2016 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per KESWICK HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Alexander Edward Compton Hare come amministratore in data 05 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come segretario in data 05 ott 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sandra Judith Odell come amministratore in data 05 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2017 al 31 dic 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 3 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Maxwell David Shaw James come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Daniel Mark Greenslade come amministratore in data 31 mar 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Sandra Judith Odell come amministratore in data 31 mar 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard James Stearn come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Maxwell David Shaw James il 04 ago 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard James Stearn il 10 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sandra Judith Odell il 04 ago 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 16 Grosvenor Street London W1K 4QF a 43-45 Portman Square London W1H 6LY in data 05 ago 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Varie Section 519 | 4 pagine | MISC | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2013 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di KESWICK HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREENSLADE, Daniel Mark | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | 196504990001 | |||||
| HARE, Alexander Edward Compton | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 215786330001 | |||||
| CAMPBELL, Rosemary Joy | Segretario | Rosebank 19 Orchard Rise Shirley CR0 7QZ Croydon Surrey | British | 13408960001 | ||||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Segretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| EASTWOOD, Charlotte Ind | Segretario | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
| GIBSON, Timothy David | Segretario | Flat 4 90/92 Seven Sisters Road N7 6AE London | British | 50070710002 | ||||||
| HUGHES, Paul | Segretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
| ODELL, Sandra Judith | Segretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175336300001 | |||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Segretario | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | 66939460001 | ||||||
| ROBSON SKEETE, Gail | Segretario | 17 Field Close Locks Heath SO31 6TX Southampton Hampshire | British | 58498140001 | ||||||
| WOOLLEY, Peter Thomas Griffith | Segretario | 2 Fernsleigh Close SL9 0HR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 39676720001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Segretario | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
| CAMPBELL, Rosemary Joy | Amministratore | Rosebank 19 Orchard Rise Shirley CR0 7QZ Croydon Surrey | British | 13408960001 | ||||||
| CLARK, James Robert | Amministratore | Logmore 37 The Avenue SM2 7QA Cheam Surrey | United Kingdom | British | 52063220001 | |||||
| DUGDALE, Edward Stratford | Amministratore | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | 35942980003 | |||||
| DWYER, Tonianne | Amministratore | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | 94124780001 | |||||
| ELLIS, Nigel George | Amministratore | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | 14185110002 | ||||||
| GAVAGHAN, David Nicholas | Amministratore | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | 151855940001 | |||||
| HAMILTON STUBBER, James Robert | Amministratore | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | 84913850002 | |||||
| JAMES, Maxwell David Shaw | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 164108510002 | |||||
| LAZARUS, James Nicholas | Amministratore | Misbourne 47 Foxdell Way Chalfont St Peter SL9 0PL Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 8315580001 | |||||
| ODELL, Sandra Judith | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 132142980001 | |||||
| PARRETT, Gary Douglas | Amministratore | 2 Ringmer Way BR1 2TY Bickley Kent | British | 71816830001 | ||||||
| PARRETT, Mark Stephen | Amministratore | The Laurels Coopers Corner Ide Hill TN14 6LB Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 13853490001 | |||||
| PARRETT, Turrloo Francis | Amministratore | Letts Green Knockholt Shirley CR0 Croydon Surrey | British | 31464880001 | ||||||
| PARRETT, Turrloo Francis | Amministratore | Letts Green Knockholt TN14 7PG Sevenoaks Kent | British | 33840450001 | ||||||
| RILEY, Michael Edward | Amministratore | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | 94724020002 | ||||||
| SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Amministratore | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | 43632680001 | |||||
| STEARN, Richard James | Amministratore | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | 94050800002 | |||||
| WOOLLEY, Peter Thomas Griffith | Amministratore | 2 Fernsleigh Close SL9 0HR Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 39676720001 | ||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Amministratore | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | 130493170001 | |||||
| WYATT, Adrian Roger | Amministratore | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | 42858810002 |
KESWICK HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed of debenture | Creato il 08 mar 1996 Consegnato il 22 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee arising under the terms of the richard english agreement dated 19/2/96 will also be recured under the debenture dated 17/6/94 as amended by this supplemental deed of debenture dated 8/3/96 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 giu 1994 Consegnato il 23 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0