OXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE)

OXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02081352
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE)?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova OXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE)?

    Indirizzo della sede legale
    Daw Bank
    Stockport
    SK3 0DU Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE)?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DABRIM LIMITED08 dic 198608 dic 1986

    Quali sono gli ultimi bilanci di OXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per OXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012

    3 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2012

    Stato del capitale al 03 mag 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2011

    3 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    7 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 10 ott 2009

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2009

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Leslie Brian Warneford il 01 nov 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Colin Brown il 15 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 07 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 apr 2007

    4 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di OXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004
    BATH, Stephen John
    8 Elmers Way
    Bransgore
    BH23 8HB Christchurch
    Dorset
    Segretario
    8 Elmers Way
    Bransgore
    BH23 8HB Christchurch
    Dorset
    British2877760001
    BEST, Michael John
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    Segretario
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    British36339320001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    British70283550001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Segretario
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    British45931770001
    STRICKLAND, Annabelle June
    22 Cherry Tree Close
    EX4 5AT Exeter
    Devon
    Segretario
    22 Cherry Tree Close
    EX4 5AT Exeter
    Devon
    British32648300001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    WILDMAN, Lara Joanne
    17 Catalina Close
    Dunkeswell
    EX14 0QD Honiton
    Devon
    Segretario
    17 Catalina Close
    Dunkeswell
    EX14 0QD Honiton
    Devon
    British45772780001
    BLUNDRED, Harold Davies
    Ladram House
    Behind Hayes
    EX9 7JQ Otterton
    Devon
    Amministratore
    Ladram House
    Behind Hayes
    EX9 7JQ Otterton
    Devon
    British2990700001
    CARTER, Alex Paul
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Hayes
    Stubbs Road Everdon
    NN11 3BN Daventry
    Northamptonshire
    British41601830001
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Amministratore
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    British70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Amministratore
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritish70283550001
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Amministratore
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Amministratore
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritish2268190002
    JEFFERY, Patricia Janet
    Millburn House
    8 Five Acres
    OX5 2RP Murcott
    Oxfordshire
    Amministratore
    Millburn House
    8 Five Acres
    OX5 2RP Murcott
    Oxfordshire
    British2990710006
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    LYON, Inglis
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    102 Lewis Road
    Radford Semele
    CV31 1UP Leamington Spa
    Warwickshire
    British72280120001
    MCDONALD, Russell Wayne
    Winsham 8 Barton Close
    Exton
    EX3 0PE Exeter
    Amministratore
    Winsham 8 Barton Close
    Exton
    EX3 0PE Exeter
    British54579150001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Amministratore
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritish73518280001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Amministratore
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    United KingdomBritish45931770001
    STURTRIDGE, Gerald Arthur
    The Lugger 2 Globe Ley
    Globefield Topsham
    EX3 0DL Exeter
    Devon
    Amministratore
    The Lugger 2 Globe Ley
    Globefield Topsham
    EX3 0DL Exeter
    Devon
    United KingdomBritish105163380001

    OXFORD BUS COMPANY LIMITED(THE) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 ago 1996
    Consegnato il 14 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 gen 1991
    Consegnato il 25 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 25 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 25 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0