GREENBARR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGREENBARR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02090236
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GREENBARR LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova GREENBARR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Micros Fidelio House
    6-8 The Grove
    SL1 1QP Slough
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GREENBARR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED27 feb 198727 feb 1987
    VISUALANNUAL LIMITED16 gen 198716 gen 1987
    INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED16 gen 198716 gen 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di GREENBARR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GREENBARR LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GREENBARR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 dic 2013

    Stato del capitale al 10 dic 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010

    2 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 04 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Gary Kaufman come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2009

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2008

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2007

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di GREENBARR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WALDER, Stephen
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    Segretario
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    British41833080003
    NIROOMAND, Kaweh
    Salzach Strasse 55a
    FOREIGN 14129 Berlin
    Germany
    Amministratore
    Salzach Strasse 55a
    FOREIGN 14129 Berlin
    Germany
    UsaIranian119291160001
    WALDER, Stephen
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    Amministratore
    The Old Brew House
    Brewery Common
    RG7 3JE Mortimer
    Berkshire
    United KingdomBritish41833080003
    WARD, Frank Peter
    30 Bridle Road
    SL6 7RP Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    30 Bridle Road
    SL6 7RP Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomIrish118809190001
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Segretario
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    British39034110001
    COTTRELL, Paul Alan
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    Segretario
    16 Goldcrest Drive
    TN22 5QG Uckfield
    East Sussex
    British13754300002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GALL, Alan Farquhar
    4 Wellesley Road
    TW2 5RS Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    4 Wellesley Road
    TW2 5RS Twickenham
    Middlesex
    British1728300001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Segretario
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    BAKER, Carl Howard
    The Croft Clews Lane
    GU24 9DZ Bisley
    Surrey
    Amministratore
    The Croft Clews Lane
    GU24 9DZ Bisley
    Surrey
    British58321590001
    BRADLEY, Michael John
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    Amministratore
    Vantage Point
    208 Henwick Road
    WR2 5PF Worcester
    British40818740003
    COBY, Alan John
    Windermere Lodge Friday Street
    Pebworth
    CV37 8XW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Windermere Lodge Friday Street
    Pebworth
    CV37 8XW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British50358320001
    COBY, Helen Mary
    The Plantation House Hotel
    Ermington
    PL21 9NS Ivybridge
    Devon
    Amministratore
    The Plantation House Hotel
    Ermington
    PL21 9NS Ivybridge
    Devon
    British80139540001
    CODGAN, James Raymond
    32 King Edwards Road
    SL5 8NY Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    32 King Edwards Road
    SL5 8NY Ascot
    Berkshire
    British19597140001
    COSTER, Malcolm David
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    Amministratore
    Rivendell 46 Golfside
    South Cheam
    SM2 7EZ Sutton
    Surrey
    EnglandBritish39034110001
    EVANS, Robert Owen
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Hollybank
    32 Birches Lane
    CV8 2AD Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    KAUFMAN, Gary
    10203 Castehill Court
    Ellicott
    Md 21042
    Usa
    Amministratore
    10203 Castehill Court
    Ellicott
    Md 21042
    Usa
    UsaAmerican118968570001
    LOMAX, Christopher Morris David
    4 Greenwood Road
    WA13 0LA Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    4 Greenwood Road
    WA13 0LA Lymm
    Cheshire
    British32315330001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MATTHEW, Gordon John
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    Amministratore
    Rogers Lane
    Ettrington
    CV37 3TA Stratford Upon Avon
    Saracens Yard
    Warwickshire
    EnglandBritish151547160001
    NORTON, John Laurence
    4 Waveney Close
    OX6 8GP Bicester
    Oxfordshire
    Amministratore
    4 Waveney Close
    OX6 8GP Bicester
    Oxfordshire
    British34339250001
    O'LEARY, Michael Kevin
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Greenwood
    Wichenford
    WR6 6YB Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish129193560001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WINGFIELD, Richard Alan
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    Amministratore
    1 Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    EnglandBritish76932830002

    GREENBARR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Credit agreement
    Creato il 18 lug 1991
    Consegnato il 25 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £53,003.16 due from the company to the chargee under the terms of the agreement.
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 25 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 13 mar 1991
    Consegnato il 20 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £15949-24 due from the company under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All right, title and interest under the insurance. See form 395 (ref 495).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 20 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 10 mag 1990
    Consegnato il 22 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to all sums payable under the insurances see form 395 (ref 136) for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 22 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 12 apr 1989
    Consegnato il 27 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Brevi particolari
    All its right, title & interest in & to all sums payable (including by way of refund (under the insurances. As from time time varied or extended & the benfit of all powers & remedies for cancelling and/or enforcing the same. (For full details see form M395-M50C).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 27 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 mar 1987
    Consegnato il 17 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 07 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0