GREENBARR LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GREENBARR LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02090236 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GREENBARR LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova GREENBARR LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Micros Fidelio House 6-8 The Grove SL1 1QP Slough Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GREENBARR LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED | 27 feb 1987 | 27 feb 1987 |
| VISUALANNUAL LIMITED | 16 gen 1987 | 16 gen 1987 |
| INNSITE HOTEL SERVICES LIMITED | 16 gen 1987 | 16 gen 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GREENBARR LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GREENBARR LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per GREENBARR LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2010 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gary Kaufman come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2009 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 nov 2009 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2008 | 3 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 190 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2007 | 3 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GREENBARR LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALDER, Stephen | Segretario | The Old Brew House Brewery Common RG7 3JE Mortimer Berkshire | British | 41833080003 | ||||||
| NIROOMAND, Kaweh | Amministratore | Salzach Strasse 55a FOREIGN 14129 Berlin Germany | Usa | Iranian | 119291160001 | |||||
| WALDER, Stephen | Amministratore | The Old Brew House Brewery Common RG7 3JE Mortimer Berkshire | United Kingdom | British | 41833080003 | |||||
| WARD, Frank Peter | Amministratore | 30 Bridle Road SL6 7RP Maidenhead Berkshire | United Kingdom | Irish | 118809190001 | |||||
| COSTER, Malcolm David | Segretario | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | British | 39034110001 | ||||||
| COTTRELL, Paul Alan | Segretario | 16 Goldcrest Drive TN22 5QG Uckfield East Sussex | British | 13754300002 | ||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Segretario | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||
| GALL, Alan Farquhar | Segretario | 4 Wellesley Road TW2 5RS Twickenham Middlesex | British | 1728300001 | ||||||
| TAYLOR, David | Segretario | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
| BAKER, Carl Howard | Amministratore | The Croft Clews Lane GU24 9DZ Bisley Surrey | British | 58321590001 | ||||||
| BRADLEY, Michael John | Amministratore | Vantage Point 208 Henwick Road WR2 5PF Worcester | British | 40818740003 | ||||||
| COBY, Alan John | Amministratore | Windermere Lodge Friday Street Pebworth CV37 8XW Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 50358320001 | ||||||
| COBY, Helen Mary | Amministratore | The Plantation House Hotel Ermington PL21 9NS Ivybridge Devon | British | 80139540001 | ||||||
| CODGAN, James Raymond | Amministratore | 32 King Edwards Road SL5 8NY Ascot Berkshire | British | 19597140001 | ||||||
| COSTER, Malcolm David | Amministratore | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | England | British | 39034110001 | |||||
| EVANS, Robert Owen | Amministratore | Hollybank 32 Birches Lane CV8 2AD Kenilworth Warwickshire | British | 57011000001 | ||||||
| GRAHAM, Ross King | Amministratore | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||
| KAUFMAN, Gary | Amministratore | 10203 Castehill Court Ellicott Md 21042 Usa | Usa | American | 118968570001 | |||||
| LOMAX, Christopher Morris David | Amministratore | 4 Greenwood Road WA13 0LA Lymm Cheshire | British | 32315330001 | ||||||
| LOMAX, John Kevin | Amministratore | Hawling Manor Hawling GL54 5TA Cheltenham Gloucestershire | British | 22190280002 | ||||||
| MATTHEW, Gordon John | Amministratore | Rogers Lane Ettrington CV37 3TA Stratford Upon Avon Saracens Yard Warwickshire | England | British | 151547160001 | |||||
| NORTON, John Laurence | Amministratore | 4 Waveney Close OX6 8GP Bicester Oxfordshire | British | 34339250001 | ||||||
| O'LEARY, Michael Kevin | Amministratore | Greenwood Wichenford WR6 6YB Worcester Worcestershire | England | British | 129193560001 | |||||
| TAYLOR, David | Amministratore | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Amministratore | 1 Town Farm Close Thame OX9 2DA Oxford | England | British | 76932830002 |
GREENBARR LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Credit agreement | Creato il 18 lug 1991 Consegnato il 25 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £53,003.16 due from the company to the chargee under the terms of the agreement. | |
Brevi particolari All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 13 mar 1991 Consegnato il 20 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £15949-24 due from the company under the terms of the agreement | |
Brevi particolari All right, title and interest under the insurance. See form 395 (ref 495). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 10 mag 1990 Consegnato il 22 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All its right title and interest in and to all sums payable under the insurances see form 395 (ref 136) for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 12 apr 1989 Consegnato il 27 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee | |
Brevi particolari All its right, title & interest in & to all sums payable (including by way of refund (under the insurances. As from time time varied or extended & the benfit of all powers & remedies for cancelling and/or enforcing the same. (For full details see form M395-M50C). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 10 mar 1987 Consegnato il 17 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0