UCI DEVELOPMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | UCI DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02090653 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
- Attività di distribuzione di film cinematografici (59131) / Informazione e comunicazione
Dove si trova UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| UCI DEVELOPMENTS (UK) LIMITED | 02 mag 1989 | 02 mag 1989 |
| CIC | 12 gen 1989 | 12 gen 1989 |
| AMC DEVELOPMENTS (UK) LIMITED | 22 apr 1987 | 22 apr 1987 |
| GOLDENVISUAL LIMITED | 19 gen 1987 | 19 gen 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX a 1 More London Place London SE1 2AF in data 06 ott 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Kirsten Lawton come segretario in data 18 mag 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di un amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di un amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di un amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Brooks Rainer come amministratore in data 18 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kirsten Lawton come segretario in data 18 mag 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil James Williams come amministratore in data 18 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Jonathan Way come amministratore in data 18 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Stephen Alker come amministratore in data 18 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Michael Donovan come amministratore in data 30 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Kirsten Lawton il 04 ago 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAINER, John Brooks | Amministratore | More London Place SE1 2AF London 1 | United States | American | 230136900001 | |||||
| FOX, Carol Collins | Segretario | Lee House 90 Greay Bridgewater Street M1 5JW Manchester | British | 34028170003 | ||||||
| JAGANNATH, Vidya | Segretario | 4 Caterham Avenue BL3 3RF Bolton Lancashire | British | 104920640001 | ||||||
| LAWTON, Kirsten | Segretario | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | British | 50045660003 | ||||||
| MCDONAGH, John James | Segretario | 6 Redesmere Close Timperley WA15 7EE Altrincham Cheshire | British | 38769610001 | ||||||
| RIBBONS, Justin Charles | Segretario | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| RICHARDS, James Timothy | Segretario | 8a Marides Road Kensington W8 2LJ London | British | 30429210001 | ||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Segretario | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
| ALKER, Andrew Stephen | Amministratore | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | 120642230001 | |||||
| DONOVAN, Paul Michael | Amministratore | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England And Wales United Kingdom | England | British | 154988050002 | |||||
| GAVIN, Alexander Rupert | Amministratore | Whitcomb Street WC2H 7DN London 54 | England | British | 16875680005 | |||||
| GOSLING, Steven Paul | Amministratore | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 124301460001 | |||||
| HARRIS, Roger John | Amministratore | Green Villa Park SK9 6EJ Wilmslow 14 Cheshire | United Kingdom | British | 129109390001 | |||||
| HILDRED, Richard John | Amministratore | 3 Beech Hill Mobberley WA16 7HT Cheshire | United Kingdom | British | 112979700001 | |||||
| HILDRED, Richard John | Amministratore | 3 Beech Hill Mobberley WA16 7HT Cheshire | United Kingdom | British | 112979700001 | |||||
| RIBBONS, Justin Charles | Amministratore | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| RIBBONS, Justin Charles | Amministratore | Strayleaves 8 Elm Rise SK10 4US Prestbury Cheshire | British | 23745010013 | ||||||
| SINYOR, Joseph | Amministratore | 70 Sheldon Avenue N6 4ND London | United Kingdom | British | 142528420002 | |||||
| WAY, Mark Jonathan | Amministratore | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | 191239860001 | |||||
| WILLIAMS, Neil James | Amministratore | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 194329360001 | |||||
| ESSENTIAL CINEMAS BV | Amministratore | Amsteldijk 166 1079 Lh Amsterdam Netherlands | 102479600001 | |||||||
| UNITED CINEMAS INTERNATIONAL MULTIPLEX BV | Amministratore | Amsteldijk 166 1079 Lh Amsterdam Netherlands | 102479570001 | |||||||
| UNIVERSAL STUDIOS HOLDING III CORP | Amministratore | 800 Third Avenue New York Ny 10022 Usa | 98626030001 | |||||||
| UNIVERSAL STUDIOS INTERNATIONAL BV | Amministratore | Hagedoornlaan 2 PO BOX 37267 FOREIGN Amsterdam 1030 Ag | 30239060004 | |||||||
| VIACOM INTERNATIONAL (NETHERLANDS) BV | Amministratore | Naritaweg 207 1043 Cb Amsterdam The Netherlands | 37696370007 |
Chi sono le persone con controllo significativo di UCI DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Cinemas International (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
UCI DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security registered in scotland on 28/2/91 | Creato il 28 feb 1991 Consegnato il 11 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee terms of a personal bond dated 4TH & 10TH october 1990 | |
Brevi particolari All & whole the tenants part of lease relating to all & whole that area of ground extending 0.640 hectares in the clydesbank district of strathclyde region forming part of phase 111 of the clyde shopping centre, title no dmb 22832. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 dic 1989 Consegnato il 18 dic 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Not exceeding £110,000,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of letter of credit, the overdraft facility and any relevant collateral dcoument (as defined) | |
Brevi particolari (See doc M395 ref M263L for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental loan agreement | Creato il 07 nov 1989 Consegnato il 22 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £64,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12/12/88 and this deed | |
Brevi particolari Floating charge over (see doc M551C for full details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental loan agreement | Creato il 14 set 1989 Consegnato il 19 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement dated 12/12/88 and this deed | |
Brevi particolari Floating charge over (see 395-tc no. 213 for further details). Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental loan agreement, | Creato il 16 giu 1989 Consegnato il 03 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £48,300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a loan agreement dated 12TH december 1988 and this supplemental loan agreement | |
Brevi particolari Floating charge over all the undertaking, property assets and rights (see for 395 relative to this charge ref m 568C for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Loan agreement | Creato il 12 dic 1988 Consegnato il 28 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from amc entertainments (UK) limited and/or CIC multiplex cinemas B.V. to the chargee under the terms of the loan agreement | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all the undertaking, property assets and rights (please refer to doc M395 ref M364 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
UCI DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0