REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED

REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREGENCY AUTOMOTIVE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02101161
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EVANS HALSHAW LIMITED08 mar 200508 mar 2005
    REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED04 mar 200504 mar 2005
    CADILLAC GB LIMITED09 set 200409 set 2004
    REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED19 ott 199219 ott 1992
    MERLIN (CAMBRIA) LIMITED27 mar 198727 mar 1987
    RJT 58 LIMITED18 feb 198718 feb 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 mag 2021

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Mark Philip Herbert come amministratore in data 30 giu 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Simon Willis come amministratore in data 08 apr 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Philip Herbert come amministratore in data 01 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Paul Holden come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Trevor Garry Finn come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard James Maloney come segretario in data 01 gen 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Garry Finn il 18 ott 2016

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    222141180001
    WILLIS, Mark Simon
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish229010610001
    PENDRAGON MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2304195
    50880100004
    HIBBERT, David Anthony
    Station Approach
    Duffield
    DE56 4HP Derby
    5
    Derbyshire
    Segretario
    Station Approach
    Duffield
    DE56 4HP Derby
    5
    Derbyshire
    British128766470001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    British41559790001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish2652610013
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Amministratore
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritish55127120002
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish123285980005
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish148034310003
    QUIGG, Kevin Barry
    8 Derby Road
    Duffield
    DE56 4FL Derby
    Amministratore
    8 Derby Road
    Duffield
    DE56 4FL Derby
    United KingdomBritish97015090001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish41559790001
    WHEELER, Ian
    Brookfield House
    Snelston
    DE6 2EP Ashbourne
    Derby Derbyshire
    Amministratore
    Brookfield House
    Snelston
    DE6 2EP Ashbourne
    Derby Derbyshire
    British2685820010

    Chi sono le persone con controllo significativo di REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Pendragon Motor Group Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione2163998
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    REGENCY AUTOMOTIVE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 13 mag 2009
    Consegnato il 21 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transazioni
    • 21 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0