SJPC 7 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSJPC 7 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02102279
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SJPC 7 LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova SJPC 7 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St. James'S Place House
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SJPC 7 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANGLO GROUP LIMITED23 feb 198723 feb 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di SJPC 7 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SJPC 7 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SJPC 7 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Nomina di Mrs Susan Meech come amministratore in data 12 dic 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Charles Woodd come amministratore in data 12 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Charles Bellamy come amministratore in data 12 dic 2014

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di St James's Place Administration Limited come segretario in data 07 ott 2014

    1 pagineTM02

    Nomina di St. James's Place Corporate Secretary Limited come segretario in data 07 ott 2014

    2 pagineAP04

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2014

    Stato del capitale al 28 ago 2014

    • Capitale: GBP .1
    SH01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2013

    11 pagineAA

    legacy

    187 paginePARENT_ACC

    Stato del capitale al 18 giu 2014

    • Capitale: GBP 0.10
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c and cap redemption reserve/ re dividend 14/05/2014
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    legacy

    164 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di SJPC 7 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ST. JAMES'S PLACE CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    Segretario
    1 Tetbury Road
    GL7 1FP Cirencester
    St. James's Place House
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione9131866
    192131860001
    CROFT, Andrew Martin
    Wythburn Court
    34 Seymour Place
    W1H 7NS London
    16
    Amministratore
    Wythburn Court
    34 Seymour Place
    W1H 7NS London
    16
    United KingdomBritish55940940004
    GLADMAN, Hugh John
    Mole End
    Woodmancote
    GL7 7EA Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Mole End
    Woodmancote
    GL7 7EA Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish41485310006
    MEECH, Susan Margaret
    Swinbrook
    OX18 4ED Burford
    The Forge
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Swinbrook
    OX18 4ED Burford
    The Forge
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritish193649900001
    WOODD, Charles
    St Peter's Road
    GL7 1RG Cirencester
    18
    Gloucestershire
    England
    Amministratore
    St Peter's Road
    GL7 1RG Cirencester
    18
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish193649250001
    LEATHERS, Michael Russell
    64 Sloane Street
    SW1X 9SH London
    Segretario
    64 Sloane Street
    SW1X 9SH London
    British68813320001
    ST JAMES'S PLACE ADMINISTRATION LIMITED
    Saint James S Place House
    Dollar Street
    GL7 2AQ Cirencester
    Gloucestershire
    Segretario
    Saint James S Place House
    Dollar Street
    GL7 2AQ Cirencester
    Gloucestershire
    77087000002
    BAILEY, Charles Howard
    Beeches
    Franks Fields
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    Amministratore
    Beeches
    Franks Fields
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    United KingdomBritish1992450001
    BELL, Ronald Edward, Mr.
    Glendevon 1a Woodpecker Close
    Ewshot
    GU10 5TH Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Glendevon 1a Woodpecker Close
    Ewshot
    GU10 5TH Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish119280590001
    BELLAMY, David Charles
    Beechwood House 35 Stone Lane
    Lydiard Millicent
    SN5 9LD Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    Beechwood House 35 Stone Lane
    Lydiard Millicent
    SN5 9LD Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritish84428640001
    CONNON, Daniel Francis
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Elmhurst Dundle Road
    Matfield
    TN12 7HD Tonbridge
    Kent
    British35128740001
    CRACKNELL, John David
    Mark House Aviary Road
    Pyrford
    GU22 8TH Woking
    Surrey
    Amministratore
    Mark House Aviary Road
    Pyrford
    GU22 8TH Woking
    Surrey
    EnglandBritish637610001
    GIBSON, Clive Patrick, The Honourable
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    Amministratore
    Monmouth House
    29a Hyde Park Gate
    SW7 5DJ London
    British45468220001
    JOHNSTON, John Walford Philip
    58 Hampton Road
    TW11 0JX Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    58 Hampton Road
    TW11 0JX Teddington
    Middlesex
    British40292700001
    LANGFIELD, Andrea Valerie
    Old Brooklands
    Metherell
    PL17 8DB Callington
    Cornwall
    Amministratore
    Old Brooklands
    Metherell
    PL17 8DB Callington
    Cornwall
    British52526910001
    MOULE, Martin David
    East Barn Limes Road
    Kemble
    GL7 6AD Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    East Barn Limes Road
    Kemble
    GL7 6AD Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish46052530001
    RICHARDS, Kenneth Samuel
    Boytons Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Boytons Bumpstead Road
    Hempstead
    CB10 2PW Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish39995540001
    SANDERS, Stephen Robin
    4 Juniper Close
    Badger Farm
    SO22 4LU Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    4 Juniper Close
    Badger Farm
    SO22 4LU Winchester
    Hampshire
    British38839120001
    STAFFORD-DEITSCH, Andrew
    77 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    Amministratore
    77 Ellerby Street
    SW6 6EU London
    Us Citizen49540710001
    WOOD, David Neil
    Uplands 65 The Ridgeway
    TN10 4NL Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Uplands 65 The Ridgeway
    TN10 4NL Tonbridge
    Kent
    British47106420001

    SJPC 7 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge
    Creato il 05 set 1990
    Consegnato il 19 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of evendate and/or any security documents.
    Brevi particolari
    The common stock shares of sunnydale holdings limited with all divides distributies and interest.
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas for Itself and as Trustee for the Agent and Banks.
    Transazioni
    • 19 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 set 1990
    Consegnato il 19 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of evendate and/or any security documents
    Brevi particolari
    All stocks shares bonds and securities monies due therefrom see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas for Itself and as Trustee for the Agent and Banks.
    Transazioni
    • 19 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 set 1990
    Consegnato il 19 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of evendate and/or any security documents
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of the company with the trustee see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas for Itself and as Trustee for the Agent and Banks.
    Transazioni
    • 19 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 set 1990
    Consegnato il 19 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of evendate and/or any security documents
    Brevi particolari
    All monies from time to time standing to the credit of the account with hambros bank limited see form 395 for details.
    Persone aventi diritto
    • Bangue Paribas for Itself and as Trustee for the Agent & Banks.
    Transazioni
    • 19 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 set 1990
    Consegnato il 19 set 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement of even date and/or any security documents
    Brevi particolari
    All book and other debts present and future see form 395 for schedule of documents.
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas for Itself and as Trustee for the Agent and Banks.
    Transazioni
    • 19 set 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 17 lug 1990
    Consegnato il 18 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself the agent and the banks (as defined) under the terms of a loan agreement ad/or this assignment a d/or any other security document (as defined)
    Brevi particolari
    All the rights,titles benefits and interest of the company all book debts revenues etc. (for more details see form 395 ref M8).
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas as Trustee for Itself, the Agent & the Banks (As Defined).
    Transazioni
    • 18 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over securities
    Creato il 07 giu 1990
    Consegnato il 19 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for itself and the banks (as defined) under the terms of the loan agreement dated 10/7/89 and/or this charge.
    Brevi particolari
    First fixed charge over all stocks shares books ad securties including all dividends interest or other distribution (for more details see from 395 ref m 87).
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas as Agent & Trustee for Itself & the Banks (As Defined).
    Transazioni
    • 19 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 16 ott 1989
    Consegnato il 30 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself or the banks (as defined) under the terms of a loan agreement dated 10/7/89 and/or any other security document (as defined)
    Brevi particolari
    A) all rights titles benefits & interests of the company whatsoever present & future whether proprietory contractural or otherwise under or arising out of or evidesced by the documents. B) all book & other debts revenues & claims present & future (including things in action) which may give rise to a debt, revenue or claim due or owing or which may become due or owing to the company under or by fiture of the assigned documents (see form 395 ref: M36 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas
    Transazioni
    • 30 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Shares mortgage
    Creato il 11 lug 1989
    Consegnato il 31 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the banks as defined) under the terms of a loan agreement of evendate.
    Brevi particolari
    1,617,000 shares of common stock of sunningdale holdings limited & all dividends as distributions & interest (see form 395 ref M28 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas
    Transazioni
    • 31 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over a deposit
    Creato il 10 lug 1989
    Consegnato il 28 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the banks (as defined) under the terms of a facility agreement of evendate.
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of on account of the company with the agent which is designated "cash collatereal account re anglo group".
    Persone aventi diritto
    • Banque Paribas
    Transazioni
    • 28 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0