GENERALOUTER LIMITED

GENERALOUTER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGENERALOUTER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02109382
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GENERALOUTER LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova GENERALOUTER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Daw Bank
    Stockport
    SK3 0DU Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GENERALOUTER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per GENERALOUTER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01
    A1A5MO43

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 01 mag 2011

    16 pagineRP04
    A19Q80VU

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2012

    Stato del capitale al 06 giu 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01
    Note
    DataNota
    06 giu 2012Clarification A second filed AR01 was registered on 06/06/2012
    X185W6WJ

    Stato del capitale al 23 mar 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19
    A15B1NX5

    legacy

    1 pagineSH20
    Q159UQX4

    legacy

    1 pagineCAP-SS
    Q159UR01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08
    A15B1NXD

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04
    A15B1NXL

    Risoluzioni

    Resolutions
    6 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2011

    4 pagineAA
    ADICTX8F

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    XK7H1U00

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2010

    4 pagineAA
    AGCRLN01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    XV40HJXT

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 10 ott 2009

    1 pagineCH03
    XGUR8J5U

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2009

    4 pagineAA
    A9I0EEWP

    Dettagli del direttore cambiati per Leslie Brian Warneford il 01 nov 2009

    2 pagineCH01
    XYJJUETY

    Dettagli del direttore cambiati per Colin Brown il 15 ott 2009

    2 pagineCH01
    XU3DUEJY

    Dettagli del segretario cambiati per Michael John Vaux il 07 ott 2009

    1 pagineCH03
    XJ953DX7

    legacy

    1 pagine288a
    XJQ1QAKR

    legacy

    1 pagine288b
    XJQ1PAKQ

    legacy

    4 pagine363a
    XBHII9MK

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    4 pagineAA
    AMXYO4J2

    legacy

    1 pagine288c
    XDW6E1F6

    Chi sono gli amministratori di GENERALOUTER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant85970020003
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director49771140004
    CLAYTON, Michael Bruce
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    Segretario
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    BritishAccountant27890500005
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    BritishAccountant70283550001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Segretario
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    BritishAccountant70283550001
    HOUSTON, Guy Alan
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    BritishAccountant54321810002
    SANKEY, John Frederick
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    Segretario
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    British7542050001
    SMITH, Richard George
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    Segretario
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    BritishFinancial Director/Chartered Accountant1817090001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    CLAYTON, Michael Bruce
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Lark Rise Longrose Lane
    Kniveton
    DE6 1JL Ashbourne
    Derbyshire
    BritishAccountant27890500005
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Amministratore
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    BritishDirector47574960002
    CONROY, Michael James
    65 Lowlands Close
    NN3 5EX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    65 Lowlands Close
    NN3 5EX Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director26775900001
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    BritishChairman70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Amministratore
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritishExecutive Director1436830002
    EDEN, Philip Brookes, Mr.
    27 Williams Close
    CB7 4FQ Ely
    Cambridgeshire
    Amministratore
    27 Williams Close
    CB7 4FQ Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector63838120003
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant70283550001
    FULLER, Alan Charles
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    Amministratore
    Freshwater Cottage 2 Chapel Brow
    Charlesworth
    SK13 5HH Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant70283550001
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Amministratore
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritishFinance Director61722690002
    GUNDEL, Jeffrey
    72 Lowick Court
    Moulton
    NN3 7TY Northampton
    Amministratore
    72 Lowick Court
    Moulton
    NN3 7TY Northampton
    BritishCompany Director37176070001
    HARGREAVES, John Banks
    2 Capel Close
    Summertown
    OX2 7LA Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 Capel Close
    Summertown
    OX2 7LA Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director4955990001
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Amministratore
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritishCompany Director2268190002
    HOUSTON, Guy Alan
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    5 Bar Croft
    Newbold
    S40 4YG Chesterfield
    Derbyshire
    BritishAccountant54321810002
    HOWITT, Malcolm
    36 Castlereagh
    Wynyard Park
    TS22 5QF Billingham
    Amministratore
    36 Castlereagh
    Wynyard Park
    TS22 5QF Billingham
    BritishCompany Chairman14928120002
    MERRYWEATHER, Paul Anthony
    42 Great Lane
    Reach
    CB5 0JF Cambridge
    Cambs
    Amministratore
    42 Great Lane
    Reach
    CB5 0JF Cambridge
    Cambs
    BritishDirector/Chairman10329770001
    MOORS, Michael Eric
    5 Ridge House
    Ridge House Drive, Festival Park
    ST1 5SJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Ridge House
    Ridge House Drive, Festival Park
    ST1 5SJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director26926420002
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    Amministratore
    8 Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    Derbyshire
    EnglandBritishAccountant73518280001
    SANKEY, John Frederick
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    Amministratore
    124 Clarence Avenue
    NN2 6PA Northampton
    BritishCompany Director7542050001
    SMITH, Richard George
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    Amministratore
    129 London Road
    PE16 6LT Chatteris
    Cambridgeshire
    BritishFinancial Director/Chartered Accountant1817090001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    BritishDirector1436810001
    STEEL, John Bell
    11 Perry Court
    Clerk Maxwell Road
    CB3 0RS Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    11 Perry Court
    Clerk Maxwell Road
    CB3 0RS Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishManaging Director10329790004
    WARNER, Barry Alfred
    20 East Butterfield Court
    Goldenash
    NN3 8JG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    20 East Butterfield Court
    Goldenash
    NN3 8JG Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector37224390001
    WILLIAMS, Stephen James
    28 Barnstaple Close
    NN3 3BH Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    28 Barnstaple Close
    NN3 3BH Northampton
    Northamptonshire
    BritishCompany Director84510700001

    GENERALOUTER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Single debenture
    Creato il 29 apr 1993
    Consegnato il 04 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 long street rd, hanslope, buckinghamshire t/no. Bm 151846.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 08 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 for full details ref M719. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 03 lug 1990
    Consegnato il 18 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land garage & dwellinghouse at hanslope buckinghamshire with all buildings & fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 1990
    Consegnato il 09 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000 due from the company to the charges.
    Brevi particolari
    Land, garage and dwellinghouse at hanslope, buckinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Trevor Samuel Johnson
    • Edward Johnson
    Transazioni
    • 09 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 17 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security amendment
    Creato il 04 mag 1988
    Consegnato il 06 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Amending the terms of a debenture dated 7.8.87.
    Brevi particolari
    The rights & interest confessed on and granted by general to spel by clause 3 of the guarantee and debenture. By clause 4 of the guarantee & debenture general covenants in relation to the property charged under the guarantee & debenture in the terms set out in the form 395 relating to the debenture fited on 20.8.87.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Eurofinance (U.K.) Limited.
    Transazioni
    • 06 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Convertible debenture
    Creato il 26 apr 1988
    Consegnato il 29 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £300,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or miloton keynes ity bus limited to the chargee under or in respect of 'the indebedness' (as that term is defined in the charge)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Pmt Limited
    Transazioni
    • 29 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 ago 1987
    Consegnato il 20 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sale agreement, a hire purchase agreement, a debenture each dated 7/8/87 (as defined) and this charge on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over and rights. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Security Pacific Eurofinance (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 20 ago 1987Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0