DOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE)

DOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02109452
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE)?

    • (7499) /

    Dove si trova DOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE)?

    Indirizzo della sede legale
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE)?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Stato del capitale al 10 gen 2011

    • Capitale: GBP 22.50
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium 09/12/2010
    RES13

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ott 2010 al 31 dic 2010

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 ott 2009

    5 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    22 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    Nomina di Mr Simon Paul Golesworthy come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher David George Thomas il 19 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Eglinton il 19 ott 2009

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Marc Duale come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Roderick Day il 19 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Sec 137 and approve aact 28/01/2009
    RES13

    Chi sono gli amministratori di DOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    THOMAS, Christopher David George
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Segretario
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    BritishCompany Secretary136331200001
    DAY, Roderick
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Amministratore
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    United KingdomBritishDirector132997840001
    EGLINTON, Peter Damian
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Amministratore
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    United KingdomBritishSvp Uk Ireland And Norway137660810001
    GOLESWORTHY, Simon Paul
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    Amministratore
    Cottons Centre 3rd Floor
    Tooley Street
    SE1 2TT London
    EnglandBritishFinance Director126710690002
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector45345090004
    FORDHAM, Andrew
    The Granary Bears
    Hay Farm Brookhay Lane
    WS13 8RG Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    The Granary Bears
    Hay Farm Brookhay Lane
    WS13 8RG Lichfield
    Staffordshire
    British110434940001
    HODGSON, Richard
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    Segretario
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    BritishFinance Director96788660001
    LYON, Joseph
    34 The Uplands
    SL9 7JG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    34 The Uplands
    SL9 7JG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishAccountant57811150001
    MORRIS, Ronald Michael
    24 Southbury
    NW8 0RY London
    Segretario
    24 Southbury
    NW8 0RY London
    BritishCompany Director28887980001
    RADTKE, Kenneth
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    Segretario
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    American96788410001
    SADLER, Kevin Andrew
    75 Lammas Avenue
    CR4 2LZ Mitcham
    Surrey
    Segretario
    75 Lammas Avenue
    CR4 2LZ Mitcham
    Surrey
    British30195170001
    CAMPBELL, Thomas Walter
    Warwick Gardens
    Kensington
    W14 8PH London
    13
    England
    Amministratore
    Warwick Gardens
    Kensington
    W14 8PH London
    13
    England
    AmericanDirector106922290002
    CROWN, Stephen Maurice
    14 Spaniards Close
    NW11 6TH London
    Amministratore
    14 Spaniards Close
    NW11 6TH London
    BritishCompany Director2996560001
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishDirector45345090004
    DUALE, Marc
    6 Bentinck Mansions
    12-16 Bentinck Street
    W1U 2ER London
    Amministratore
    6 Bentinck Mansions
    12-16 Bentinck Street
    W1U 2ER London
    FrenchDirector121593810001
    EDGE, Roderick Boris Clifford
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    The Water Tower Knoll Road
    GU7 2EJ Godalming
    Surrey
    SurreyBritishDirector15622690001
    HODGSON, Richard
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    Amministratore
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    BritishFinance Director96788660001
    MORRIS, Ronald Michael
    24 Southbury
    NW8 0RY London
    Amministratore
    24 Southbury
    NW8 0RY London
    BritishCompany Director28887980001
    NICHOLLS, Christopher Robin
    16 Hartland Way
    SM4 5QN Morden
    Surrey
    Amministratore
    16 Hartland Way
    SM4 5QN Morden
    Surrey
    BritishCompany Director8731600001
    PRICE, Phillip John
    Broadway House
    Chartridge
    HP5 2TT Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Broadway House
    Chartridge
    HP5 2TT Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector119570600001
    PROWSE, John
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    Amministratore
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    EnglandBritishManaging Director96786510001
    RADTKE, Kenneth
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    Amministratore
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    AmericanCompany Director96788410001
    SADLER, Kevin Andrew
    75 Lammas Avenue
    CR4 2LZ Mitcham
    Surrey
    Amministratore
    75 Lammas Avenue
    CR4 2LZ Mitcham
    Surrey
    BritishCompany Director30195170001
    SMITH, Nicholas Paul
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    Amministratore
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    United KnigdomBritishDirector32981540001
    STRATHDEE, Niall Alistair
    23 Marston Road
    OX9 3YG Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    23 Marston Road
    OX9 3YG Thame
    Oxfordshire
    BritishSales Director40592250001
    TENNANT, Peter Robert
    116 Somerset Road
    Wimbledon
    SW19 5LA London
    Amministratore
    116 Somerset Road
    Wimbledon
    SW19 5LA London
    BritishCompany Director8736440001

    DOCUMENT STORAGE COMPANY LIMITED(THE) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 mar 2004
    Consegnato il 10 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the right, title and interest in and to 1.1 the real property 1.2 the tangible moveable property 1.3 the accounts 1.4 the intellectual property 1.5 any goodwill 1.6 the investments 1.7 the shares, all dividends, interest and other monies 1.8 all monetary claims. By way of floating charge all assets and undertaking not effectivley charged. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 mag 2003
    Consegnato il 23 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the arranger, the original lenders, the agent and the chargee or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 ago 1998
    Consegnato il 05 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at harpway lane sopley hampshire t/no.HP467576. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 feb 1997
    Consegnato il 10 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 set 1995
    Consegnato il 19 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 ago 1993
    Consegnato il 19 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being land near sopley hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 lug 1992
    Consegnato il 14 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Second & third floors, 537 norwood road l/b of lambeth t/no: sgl 462813.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mar 1991
    Consegnato il 12 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 apr 1990
    Consegnato il 04 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the south of warren row land upper wargrave windsor and maidenhead berkshire t/n bk 275863 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 dic 1988
    Consegnato il 22 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and underground accomodation of bowsey hill, warren row upper wargrave berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 13 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0