CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED

CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02110320
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RENTCO INTERNATIONAL LIMITED25 set 198725 set 1987
    VISORHEAD LIMITED13 mar 198713 mar 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2015
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2016
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Seconda presentazione per la nomina di Neil Smith come amministratore

    6 pagineRP04AP01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT a 1 More London Place London SE1 2AF in data 25 apr 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 mar 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di T I P Europe Limited come amministratore in data 05 feb 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Cakebread come amministratore in data 01 feb 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Neil Campbell Smith come amministratore in data 05 feb 2016

    3 pagineAP01
    Note
    DataNota
    06 ott 2016Clarification A second filed AP01 was registered on 06/10/2016

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2015

    Stato del capitale al 04 nov 2015

    • Capitale: GBP .1
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    16 pagineAA

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Scissione delle azioni al 01 dic 2014

    8 pagineSH02

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    capital

    Risoluzioni

    11,000,000 issued cumulative redeemable preference shares of £1 be sub-divided into 110,000,000 cumulative redeemable preference shares of £0.10 each 01/12/2014
    RES13

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 09 dic 2014

    • Capitale: GBP 0.10
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account to nil 01/12/2014
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 dic 2014

    Stato del capitale al 01 dic 2014

    • Capitale: GBP 356,027,000
    SH01

    Varie

    Section 519
    3 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    3 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    SMITH, Neil Campbell
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Amministratore
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183029170001
    SWITHENBANK, Joseph Preston
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    Amministratore
    Rue Pillet Will
    75009 Paris
    2-4
    France
    FranceUs Citizen183236480001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Segretario
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Segretario
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    SMITH, Nicholas Handran
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Segretario
    Flat 2
    19 Netherhall Gardens
    NW3 5RL Hampstead
    London
    Australian50914130001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Segretario
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Amministratore
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritish100238650001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Amministratore
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritish183172770001
    CAMFIELD, Ronald Frederick
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    Amministratore
    Nicholas House
    14 Creekview Road
    CM3 5GU South Woodham Ferrers
    Essex
    British81395090001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Amministratore
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    British53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Amministratore
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    British91783950001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Amministratore
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    British65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Amministratore
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    British3485960001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Amministratore
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritish61314280001
    FOSTER, Roy Garvin
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    16 Thameside
    RG9 1BH Henley On Thames
    Oxfordshire
    British37099790001
    GOODWIN, Eric
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    Amministratore
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    EnglandBritish45623310001
    GOODWIN, Stephen Keith
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    Amministratore
    Tumblewood Cottage 23 Beacon Way
    SM7 1DZ Banstead
    Surrey
    British5343520001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish109591300001
    IRVING, Ian Richard
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    Amministratore
    3 Warrington Crescent
    Little Venice
    W9 1ED London
    EnglandBritish41228040001
    MATTHEWS, Terence
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    Amministratore
    Flat 6
    Fleming House 20 Danvers Street Chel
    SW3 London
    British31419450002
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Amministratore
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    British65130630002
    OSBORNE, Richard Wallace Gollin Osborne
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Amministratore
    5 Northfield Wall
    59 North Road Highgate
    N6 London
    Australian17452320001
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    British4764800001
    RAINE, Richard Denby
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    Amministratore
    1 Acris Street
    SW18 2QT London
    British50519950001
    RIEDIJK, Hans Arie
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Amministratore
    Trompenburo Straat 10m
    1079 TX Amsterdam
    The Netherlands
    Dutch57483360001
    SMITS, Robert Anthony
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Amministratore
    Heemraadschapslaan 2
    1181 Vb
    Amstelveen
    Dutch54592350001
    STONE, Richard
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    Amministratore
    6 Birchways
    WA4 5DQ Appleton
    Cheshire
    British75179060001
    THRASHER III, Barrie Holt
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    Amministratore
    Flat 10
    25 Queensgate Gardens
    SW7 5RR London
    American65472750001
    WILSON, Peter Samuel
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    5 Thorn Close
    RG11 4SQ Wokingham
    Berkshire
    British59565220001
    T I P EUROPE LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    65164760003

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 26 lug 1996
    Consegnato il 30 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 30 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 23 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to an indemnity contained in a sale agreement dated 14TH december 1989 and this deed (as defined therein)
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company in and to both of the company's accounts no: 76653161 and 7943407. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC Barclays Mercantile Limited and Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 23 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 mar 1994
    Consegnato il 21 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a credit agreement dated 13TH february 1994 as amended on 15TH february 1994 and an agreement dated 15TH march 1994 (as defined) and any other related security documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.("the Security Trustee")as Security Trustee for Itself and for the Secured Parties (As Defined in the Debenture)
    Transazioni
    • 21 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 18 mag 1987
    Consegnato il 26 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as agent and trustee for the banks and/ohe overdraft bank as defined in the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Bank and Overdraft Bank
    Transazioni
    • 26 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 18 mag 1987
    Consegnato il 26 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever agent and turstee for the banks and/or the overdroft bank as defired in the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Banks and the Overdraft Bank
    Transazioni
    • 26 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 10 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CENTRAL TRAILER RENTCO INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mar 2016Inizio della liquidazione
    16 apr 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0