LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED

LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLOMBARD VENTURE LEASING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02115573
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED?

    • (6523) /

    Dove si trova LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Princess Way
    Redhill
    RH1 1NP Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WORLDMEDIUM LIMITED26 mar 198726 mar 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 ago 2011

    Stato del capitale al 02 ago 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Kirsty Daly come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lindsey Cameron come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard Priestman come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Cessazione della carica di Neeraj Kapur come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Andrew David Barnard come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    22 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    23 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    23 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DALY, Kirsty
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    Segretario
    Glasgow Road
    EH12 1HQ Edinburgh
    Rbs Gogarburn
    Scotland
    161014920001
    BALDOCK, Alexander David
    Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    218
    United Kingdom
    Amministratore
    Westbourne Park Road
    W11 1EP London
    218
    United Kingdom
    United KingdomBritish132330380001
    BARNARD, Andrew David
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Bell Cottage
    Bell Road
    RH12 3QL Warnham
    Bell Cottage
    West Sussex
    England
    EnglandBritish137736080001
    CLIBBENS, Nigel Timothy John
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    40a Pennington Road
    Southborough
    TN4 0SL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish49141230004
    BROMLEY, Heidi Elizabeth
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    Segretario
    40 Hitchings Way
    RH2 8EW Reigate
    Surrey
    British33605720002
    CAMERON, Lindsey Helen
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Segretario
    The Terrace
    Glenlomond
    KY13 9HF Kinross
    Suite Gleann Cottage, 1
    Other132335590001
    CUNNINGHAM, Angela Mary
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    Segretario
    26 Green Acres
    Park Hill
    CR0 5UW Croydon
    Surrey
    British62801910001
    EVANS, Margaret Janet
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    Segretario
    17 Coniston Way
    RH2 0LN Reigate
    Surrey
    British2289880001
    STRANAGHAN, Patricia Ann
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    Segretario
    Flat 1
    25 Somers Road
    RH2 9DY Reigate
    Surrey
    British39114460001
    WHITTAKER, Carolyn Jean
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Segretario
    6 Whitewood Cottages
    Whitewood Lane
    RH9 8JR South Godstone
    Surrey
    Other67499700003
    WRAITH CARTER, Gillian
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    Segretario
    8 Great Lime Kilns
    Southwater
    RH13 9JL Horsham
    West Sussex
    British109333000001
    ASHWORTH, George Smith-Salmond
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Laurelsfield
    AL3 4BZ St Albans
    Hertfordshire
    EnglandEnglish152638710001
    BEESTON, Alistair John
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Three Oaks Vauxhall Lane
    Southborough
    TN4 0XD Tunbridge Wells
    Kent
    British10670790001
    CARTE, Brian Addison
    Fairfield Lodge
    Hardwick Close Knott Park
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Fairfield Lodge
    Hardwick Close Knott Park
    KT22 0HZ Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritish145559220001
    CLEMETT, Graham Colin
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    Amministratore
    15 Winchester Close
    KT10 8QH Esher
    Surrey
    United KingdomBritish123744930001
    FITCH, John Derek
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    Amministratore
    Douglas Cottage
    Coombe End
    KT2 7DQ Kingston
    Surrey
    British8461210001
    HIGGINS, Peter
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    Amministratore
    2 Grange Close
    RH1 4LW Bletchingley
    Surrey
    EnglandBritish107984310001
    JOHNSON, Jeffrey
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Hill House
    28 Maldon Road Danbury
    CM3 4QH Chelmsford
    Essex
    British103077710001
    KAPUR, Neeraj
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    Amministratore
    The Old Granary
    Hillside Road
    GU10 3AJ Frensham
    Surrey
    United KingdomBritish122158360001
    KNOWLES, Christopher George
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    Amministratore
    Whispering Well House
    Chander Hill Lane, Holymoorside
    S42 7HN Chesterfield
    Derbyshire
    British67501900002
    LYNAM, Paul Anthony
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    Amministratore
    24 Warwick Road
    RG2 7AX Reading
    Berkshire
    United KingdomIrish100755360001
    MABERLY, Michael Alan
    Endellion
    Money Row Green Holyport
    SL6 2NA Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Endellion
    Money Row Green Holyport
    SL6 2NA Maidenhead
    Berkshire
    British1288990001
    MARROW, Paul
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    The Shutters 2 Nightjar Close
    Ewshot
    GU10 5TQ Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish85771600001
    PEARCE, Nigel
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    Amministratore
    Willow Trees Hazelwood Lane
    CR5 3PF Chipstead
    Surrey
    United KingdomBritish63084840002
    POWELL, Martin Edward
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    Amministratore
    Monroe Station Road
    Hatfield Peverel
    CM3 2DS Chelmsford
    United KingdomBritish59795080001
    PRIESTMAN, Richard Mark
    31 Hove Park Villas
    BN3 6HH Hove
    Sussex
    Amministratore
    31 Hove Park Villas
    BN3 6HH Hove
    Sussex
    EnglandBritish74412220002
    PURDY, John Douglas
    Kendals
    Little Heath Lane, Potten End
    HP4 2RY Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Kendals
    Little Heath Lane, Potten End
    HP4 2RY Berkhamsted
    Hertfordshire
    British68943220001
    ROOME, Harry Mccrea
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    Amministratore
    The Duchies
    Mill Lane, Pirbright
    GU24 0BT Woking
    Surrey
    EnglandBritish64898180001
    STUART, John David
    69 Howards Thicket
    SL9 7NU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    69 Howards Thicket
    SL9 7NU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British76974710001
    SULLIVAN, Christopher Paul
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    Amministratore
    Princess Way
    RH1 1NP Redhill
    3
    Surrey
    United KingdomBritish67033830004

    LOMBARD VENTURE LEASING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    First panamanian naval mortgage in respect of M.V. "tarquin pride"
    Creato il 30 set 1998
    Consegnato il 15 ott 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee up to a maximum of us$25,000,000
    Brevi particolari
    All right title and interest in the vessel "tarquin pride" registered under the panamanian flag with official number 27318-pext-1. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson N.V.
    Transazioni
    • 15 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    First preferred panamanian naval mortgage in respect of M.V."tarquin forth"
    Creato il 09 set 1998
    Consegnato il 23 set 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee up to a maximum of us$25,000,000
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in the vessel "tarquin forth",registered in panama with official no.27317-pext-1. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson N.V.
    Transazioni
    • 23 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0