ARAMARK PARTNERSHIP LTD
Panoramica
Nome della società | ARAMARK PARTNERSHIP LTD |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02115952 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ARAMARK PARTNERSHIP LTD?
Indirizzo della sede legale | c/o ARAMARK LIMITED 2nd Floor 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park GU14 7JP Farnborough Hampshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CAMPBELL BEWLEY INTERNATIONAL LIMITED | 26 giu 1998 | 26 giu 1998 |
CAMPBELL CATERING INTERNATIONAL LIMITED | 27 mar 1987 | 27 mar 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 29 set 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ARAMARK PARTNERSHIP LTD?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Adrian Mark Goldacre come amministratore in data 26 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Adrian Mark Goldacre come amministratore in data 08 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Quenten Charles Wentworth come amministratore in data 08 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Clive Cooper come amministratore in data 08 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Desmond Mark Christopher Doyle come amministratore in data 31 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew William Main come amministratore in data 31 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Quenten Charles Wentworth come amministratore in data 07 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 02 ott 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Roberta Wheeler come amministratore in data 02 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 03 ott 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Aramark Limited 2Nd Floor 250 Fowler Avenue Iq Business Park Farnborough Hampshire GU14 7JP England a C/O Aramark Limited 2Nd Floor 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park Farnborough Hampshire GU14 7JP | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Aramark Limited 2Nd Floor Iq Business Park 250 Fowler Avenue Farnborough Hampshire GU14 7JP a C/O Aramark Limited 2Nd Floor 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park Farnborough Hampshire GU14 7JP in data 07 gen 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 set 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Aramark Limited, Innovation Centre London Underwriting Centre 3 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7DD United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEASY, Mary-Ann | Segretario | c/o Aramark Limited 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park GU14 7JP Farnborough 2nd Floor Hampshire England | British | Lawyer | 127820280001 | |||||
COOPER, John Clive | Amministratore | c/o Aramark Limited 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park GU14 7JP Farnborough 2nd Floor Hampshire | England | British | Vice President European Supply Chain | 221752150001 | ||||
BOSTON, Nicholas Ian | Segretario | Chestnuts Mark Way GU7 2BW Godalming Surrey | British | 158913350001 | ||||||
BROCK, Amanda Currie | Segretario | 262 Ferme Park Road Crouch End N8 9BL London | British | Solicitor | 250122310001 | |||||
DOUGLAS, Irene Crawford | Segretario | 25 Norfolk Chase Warfield RG42 3XN Bracknell Berkshire | British | Company Secretary | 72046160002 | |||||
MURPHY, Gerald Michael | Segretario | 14 Aranleigh Gardens Rathfarnham Dublin Ireland | Irish | 38220350001 | ||||||
O'SULLIVAN, Michael | Segretario | 5 Marley Grove Road IRISH Malahide Co Dublin | Irish | 177619830001 | ||||||
BELLAMY, Roger Gary | Amministratore | 7 Burnham Close West Hallam DE7 6LT Ilkeston Derbyshire | British | Company Director | 15215770001 | |||||
BEWLEY, Patrick Ernest | Amministratore | Algarve 15 Cunningham Drive Dalkey Co Dublin Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 62589890001 | ||||
BOSTON, Nicholas Ian | Amministratore | Millbank Tower 28th Floor 21-24 Millbank SW1P 4QP London | England | British | Finance Director | 158913350001 | ||||
CAHILL, John | Amministratore | 62 Royston Kimmage Road West Dublin 12 Ireland | Irish | Director | 70811380001 | |||||
CAMPBELL, Gordon Forrester | Amministratore | The Paddocks,Milestone Avenue Charvil RG10 9TN Reading Berkshire | British | Chartered Accountants | 6394940001 | |||||
CAMPBELL, Patrick | Amministratore | Brackenstown House IRISH Swords Co Dublin Ireland | Irish | Company Director | 47902750001 | |||||
CAMPBELL, Veronica | Amministratore | Brackenstown House IRISH Swords Co Dublin Ireland | Irish | Company Director | 12786260001 | |||||
CRONIN, Dan Anthony | Amministratore | Hilltown Bridge Hilltown Carrigaline Cork Cork Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 181760920001 | ||||
CUMMINS, Michael | Amministratore | Arbores Whites Cross IRISH Foxrock Dublin 18 | Irish | Director | 57944930001 | |||||
DOYLE, Desmond Mark Christopher | Amministratore | c/o Aramark Limited 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park GU14 7JP Farnborough 2nd Floor Hampshire England | England | British | Cfo | 266121440001 | ||||
FAGAN, Gerard | Amministratore | 32 Matson Lodge Drocheda Co Louth Ireland | Irish | Company Director | 33548580001 | |||||
FARRELL, John Joseph | Amministratore | Old Kiln House Church Hill Nutfield RH1 4JA Redhill Surrey | British | Company Director | 49582350001 | |||||
GERRARD, David Andrew | Amministratore | 99 Holywell Road LU6 2PD Studham Bedfordshire | British | Finance Director | 82934050002 | |||||
GOLDACRE, Adrian Mark | Amministratore | c/o Aramark Limited 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park GU14 7JP Farnborough 2nd Floor Hampshire | England | British | Hr Director | 221712170001 | ||||
HAMPTON, Paul | Amministratore | The Rookery Church Street NN6 9BZ Brixworth Northamptonshire | British | Chief Operating Officer | 103699000001 | |||||
HUGGETT, Steven Charles | Amministratore | Rees Farm Old Packards Lane Wormingford CO6 3AH Colchester Essex | United Kingdom | British | Company Director | 88165550001 | ||||
HUNTER, Brian | Amministratore | 16 Christchurch Road GL50 2PL Cheltenham Gloucestershire | British | Catering | 58930420001 | |||||
LLEWELLYN, Gwynfa | Amministratore | Elmore South Kilvington YO7 2NA Thirsk North Yorkshire | British | Caterer | 97099910001 | |||||
MAIN, Andrew William | Amministratore | c/o Aramark Limited 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park GU14 7JP Farnborough 2nd Floor Hampshire England | United Kingdom | British | Ceo | 103998070002 | ||||
TONER, William James | Amministratore | Ridgewood Crawley Drive GU15 2AA Camberley Surrey | British | Ceo | 70271530001 | |||||
VAN, Rodney | Amministratore | 110 Moorland Road SK2 7DP Woodsmoor Stockport | British | Chartered Accountant | 57174650001 | |||||
WENTWORTH, Quenten Charles | Amministratore | c/o Aramark Limited 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park GU14 7JP Farnborough 2nd Floor Hampshire | United Kingdom | American | Group President, Europe | 201773600001 | ||||
WHEELER, Roberta | Amministratore | c/o Aramark Limited 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park GU14 7JP Farnborough 2nd Floor Hampshire England | England | British | Hr Director | 113377590001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aramark Catering Limited | 06 apr 2016 | Fowler Avenue Farnborough Business Park GU14 7JP Farnborough 250 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
ARAMARK PARTNERSHIP LTD ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee | Creato il 01 apr 1999 Consegnato il 21 apr 1999 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite debenture | Creato il 29 gen 1999 Consegnato il 19 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite debenture | Creato il 29 gen 1999 Consegnato il 18 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 02 giu 1993 Consegnato il 10 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks under the terms of the facility letters or the guarantee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0