ARAMARK PARTNERSHIP LTD

ARAMARK PARTNERSHIP LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARAMARK PARTNERSHIP LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02115952
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ARAMARK PARTNERSHIP LTD?

    Indirizzo della sede legale
    c/o ARAMARK LIMITED
    2nd Floor 250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAMPBELL BEWLEY INTERNATIONAL LIMITED26 giu 199826 giu 1998
    CAMPBELL CATERING INTERNATIONAL LIMITED27 mar 198727 mar 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 set 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ARAMARK PARTNERSHIP LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Cessazione della carica di Adrian Mark Goldacre come amministratore in data 26 giu 2018

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2017

    5 pagineAA

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Adrian Mark Goldacre come amministratore in data 08 giu 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Quenten Charles Wentworth come amministratore in data 08 giu 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Clive Cooper come amministratore in data 08 giu 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Desmond Mark Christopher Doyle come amministratore in data 31 mar 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew William Main come amministratore in data 31 mar 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Quenten Charles Wentworth come amministratore in data 07 mar 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 ott 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2016

    Stato del capitale al 07 gen 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Cessazione della carica di Roberta Wheeler come amministratore in data 02 ott 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 03 ott 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 gen 2015

    Stato del capitale al 08 gen 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Aramark Limited 2Nd Floor 250 Fowler Avenue Iq Business Park Farnborough Hampshire GU14 7JP England a C/O Aramark Limited 2Nd Floor 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park Farnborough Hampshire GU14 7JP

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Aramark Limited 2Nd Floor Iq Business Park 250 Fowler Avenue Farnborough Hampshire GU14 7JP a C/O Aramark Limited 2Nd Floor 250 Fowler Avenue Farnborough Business Park Farnborough Hampshire GU14 7JP in data 07 gen 2015

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 set 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2014

    Stato del capitale al 13 gen 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Aramark Limited, Innovation Centre London Underwriting Centre 3 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7DD United Kingdom

    1 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DEASY, Mary-Ann
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    England
    Segretario
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    England
    BritishLawyer127820280001
    COOPER, John Clive
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    Amministratore
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    EnglandBritishVice President European Supply Chain221752150001
    BOSTON, Nicholas Ian
    Chestnuts
    Mark Way
    GU7 2BW Godalming
    Surrey
    Segretario
    Chestnuts
    Mark Way
    GU7 2BW Godalming
    Surrey
    British158913350001
    BROCK, Amanda Currie
    262 Ferme Park Road
    Crouch End
    N8 9BL London
    Segretario
    262 Ferme Park Road
    Crouch End
    N8 9BL London
    BritishSolicitor250122310001
    DOUGLAS, Irene Crawford
    25 Norfolk Chase
    Warfield
    RG42 3XN Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    25 Norfolk Chase
    Warfield
    RG42 3XN Bracknell
    Berkshire
    BritishCompany Secretary72046160002
    MURPHY, Gerald Michael
    14 Aranleigh Gardens
    Rathfarnham
    Dublin
    Ireland
    Segretario
    14 Aranleigh Gardens
    Rathfarnham
    Dublin
    Ireland
    Irish38220350001
    O'SULLIVAN, Michael
    5 Marley
    Grove Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Segretario
    5 Marley
    Grove Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Irish177619830001
    BELLAMY, Roger Gary
    7 Burnham Close
    West Hallam
    DE7 6LT Ilkeston
    Derbyshire
    Amministratore
    7 Burnham Close
    West Hallam
    DE7 6LT Ilkeston
    Derbyshire
    BritishCompany Director15215770001
    BEWLEY, Patrick Ernest
    Algarve
    15 Cunningham Drive
    Dalkey
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Algarve
    15 Cunningham Drive
    Dalkey
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director62589890001
    BOSTON, Nicholas Ian
    Millbank Tower 28th Floor
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Amministratore
    Millbank Tower 28th Floor
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    EnglandBritishFinance Director158913350001
    CAHILL, John
    62 Royston Kimmage Road West
    Dublin
    12
    Ireland
    Amministratore
    62 Royston Kimmage Road West
    Dublin
    12
    Ireland
    IrishDirector70811380001
    CAMPBELL, Gordon Forrester
    The Paddocks,Milestone Avenue
    Charvil
    RG10 9TN Reading
    Berkshire
    Amministratore
    The Paddocks,Milestone Avenue
    Charvil
    RG10 9TN Reading
    Berkshire
    BritishChartered Accountants6394940001
    CAMPBELL, Patrick
    Brackenstown House
    IRISH Swords
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Brackenstown House
    IRISH Swords
    Co Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director47902750001
    CAMPBELL, Veronica
    Brackenstown House
    IRISH Swords
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Brackenstown House
    IRISH Swords
    Co Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director12786260001
    CRONIN, Dan Anthony
    Hilltown Bridge
    Hilltown Carrigaline
    Cork
    Cork
    Ireland
    Amministratore
    Hilltown Bridge
    Hilltown Carrigaline
    Cork
    Cork
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director181760920001
    CUMMINS, Michael
    Arbores
    Whites Cross
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Amministratore
    Arbores
    Whites Cross
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    IrishDirector57944930001
    DOYLE, Desmond Mark Christopher
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    England
    Amministratore
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCfo266121440001
    FAGAN, Gerard
    32 Matson Lodge
    Drocheda
    Co Louth
    Ireland
    Amministratore
    32 Matson Lodge
    Drocheda
    Co Louth
    Ireland
    IrishCompany Director33548580001
    FARRELL, John Joseph
    Old Kiln House
    Church Hill Nutfield
    RH1 4JA Redhill
    Surrey
    Amministratore
    Old Kiln House
    Church Hill Nutfield
    RH1 4JA Redhill
    Surrey
    BritishCompany Director49582350001
    GERRARD, David Andrew
    99 Holywell Road
    LU6 2PD Studham
    Bedfordshire
    Amministratore
    99 Holywell Road
    LU6 2PD Studham
    Bedfordshire
    BritishFinance Director82934050002
    GOLDACRE, Adrian Mark
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    Amministratore
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    EnglandBritishHr Director221712170001
    HAMPTON, Paul
    The Rookery
    Church Street
    NN6 9BZ Brixworth
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Rookery
    Church Street
    NN6 9BZ Brixworth
    Northamptonshire
    BritishChief Operating Officer103699000001
    HUGGETT, Steven Charles
    Rees Farm
    Old Packards Lane Wormingford
    CO6 3AH Colchester
    Essex
    Amministratore
    Rees Farm
    Old Packards Lane Wormingford
    CO6 3AH Colchester
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director88165550001
    HUNTER, Brian
    16 Christchurch Road
    GL50 2PL Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    16 Christchurch Road
    GL50 2PL Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCatering58930420001
    LLEWELLYN, Gwynfa
    Elmore
    South Kilvington
    YO7 2NA Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Elmore
    South Kilvington
    YO7 2NA Thirsk
    North Yorkshire
    BritishCaterer97099910001
    MAIN, Andrew William
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    England
    Amministratore
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    England
    United KingdomBritishCeo103998070002
    TONER, William James
    Ridgewood
    Crawley Drive
    GU15 2AA Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Ridgewood
    Crawley Drive
    GU15 2AA Camberley
    Surrey
    BritishCeo70271530001
    VAN, Rodney
    110 Moorland Road
    SK2 7DP Woodsmoor
    Stockport
    Amministratore
    110 Moorland Road
    SK2 7DP Woodsmoor
    Stockport
    BritishChartered Accountant57174650001
    WENTWORTH, Quenten Charles
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    Amministratore
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    United KingdomAmericanGroup President, Europe201773600001
    WHEELER, Roberta
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    England
    Amministratore
    c/o Aramark Limited
    250 Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    2nd Floor
    Hampshire
    England
    EnglandBritishHr Director113377590001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ARAMARK PARTNERSHIP LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aramark Catering Limited
    Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    250
    England
    06 apr 2016
    Fowler Avenue
    Farnborough Business Park
    GU14 7JP Farnborough
    250
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneUk Register Of Companies
    Numero di registrazione03945980
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ARAMARK PARTNERSHIP LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 21 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties(As Defined)
    Transazioni
    • 21 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite debenture
    Creato il 29 gen 1999
    Consegnato il 19 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Equity Bank Limited
    Transazioni
    • 19 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 29 gen 1999
    Consegnato il 18 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC (As Trustee for the Secured Parties (as Defined))
    Transazioni
    • 18 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 02 giu 1993
    Consegnato il 10 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the banks under the terms of the facility letters or the guarantee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0