LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02116902 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
- Produzione di pane; produzione di prodotti freschi di pasticceria e dolci (10710) / Industrie manifatturiere
Dove si trova LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| PINGATE CATERING LIMITED | 30 mar 1987 | 30 mar 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Emmett Mcevoy come amministratore in data 20 apr 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Antony David Smith come amministratore in data 20 apr 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Andrew Mcdonald come amministratore in data 15 nov 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Suzanne Elizabeth Wise come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 34 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Avviso di rimozione della restrizione sullo statuto sociale | 2 pagine | CC02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 set 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 lug 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Suzanne Elizabeth Wise il 01 lug 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Simon Nicholas Wilbraham il 01 lug 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Michael Peeler il 01 lug 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Antony David Smith come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Peeler come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Simon Nicholas Wilbraham come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 nov 2009 con elenco completo degli azionisti | 11 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Robert Lawson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Segretario | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
| MCDONALD, Andrew John | Amministratore | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | England | British | 164670820001 | |||||
| MCEVOY, Emmett | Amministratore | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 168590540001 | |||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Amministratore | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | England | British | 125719290002 | |||||
| BURTON, Denise Patricia | Segretario | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| HARTREY, Patrick Mark | Segretario | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
| HINES, Christine Anne | Segretario | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| HOLLOWAY, David John | Segretario | 25 Edgar Road St Cross SO23 9TN Winchester Hampshire | British | 66183100001 | ||||||
| VANBERGEN, Charles Albert | Segretario | The White Cottage Childsbridge Lane Seal TN15 0BS Sevenoaks Kent | British | 7384900001 | ||||||
| WATERS, Paul Christopher | Segretario | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Segretario | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Segretario | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
| ALLNER, Andrew James | Amministratore | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | 73003300001 | ||||||
| BARRY, Peter Nigel George | Amministratore | Hall Farmhouse The Street NR16 1EZ Ashwellthorpe Norfolk | England | British | 84886660001 | |||||
| CARTER, Ian Paul | Amministratore | 2 Hedley Gardens Hedge End SO30 2WT Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 79314210001 | |||||
| CHARTERIS, Derek William | Amministratore | Belswains Lane HP3 9PT Hemel Hempstead 111 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 136986090001 | |||||
| CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Amministratore | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 98818450001 | |||||
| CROSSLEY, Nigel | Amministratore | HP9 | England | British | 145901880001 | |||||
| DARA, Alireza | Amministratore | 23 Lynwood Road W5 1JQ London | United Kingdom | British | 22461240001 | |||||
| DAVIES, Lyn Theodore | Amministratore | Cheridene 65 Bowham Avenue CF31 3PA Bridgend Mid Glamorgan | British | 34304310003 | ||||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Amministratore | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||
| FORREST, Keith Robert Mckenzie | Amministratore | 18 St Andrews Close Moreton On Lugg HR4 8DD Hereford Hereford & Worcester | British | 45838740001 | ||||||
| HARRIS, Gareth Addison | Amministratore | 18 Painters Pightle Hook RG27 9SS Basingstoke Hampshire | England | British | 152131210001 | |||||
| HOLLOWAY, David John | Amministratore | 25 Edgar Road St Cross SO23 9TN Winchester Hampshire | England | British | 66183100001 | |||||
| HOLROYD, Dean | Amministratore | 51 Grove Road SL4 1JD Windsor Berkshire | British | 64875220002 | ||||||
| HYDE, Trevor John | Amministratore | 158 Jerounds CM19 4HH Harlow Essex | British | 71827110001 | ||||||
| JONES, Martin William | Amministratore | Rose Cottage Eathorpe CV33 9DE Leamington Spa Warwickshire | British | 26034610001 | ||||||
| LAWSON, Robert | Amministratore | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | 99991140001 | |||||
| MALPUS, John James | Amministratore | Armitage House Armitage Road WS15 4AZ Armitage Staffordshire | British | 6799180003 | ||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Amministratore | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Amministratore | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| PANTER, Alan James, Mr. | Amministratore | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | 114414690002 | ||||||
| PEELER, Andrew Michael | Amministratore | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 87359710001 | |||||
| RELF, Russell Alan | Amministratore | 113 The Chase SS6 8QP Rayleigh Essex | British | 59133030001 | ||||||
| RUDDICK, Ian William | Amministratore | 32 Woodend Drive SL5 9BG Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 98350001 |
LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Borrower deed of charge between the chargors, the issuer, the working capital facility provider, the obligor account banks and the borrower security trustee (each as defined) | Creato il 28 feb 2001 Consegnato il 20 mar 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito An amount equal to the borrower secured liabilities defined as all present and future obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the borrower secured creditors (or any of them) under the transaction documents (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the transaction documents for which any obligor is liable under the transaction documents on a full indemnity basis. | |
Brevi particolari All property assets and other rights the subject of the security interests created in favour of the borrower security trustee pursuant to the borrower security documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Creato il 11 set 2000 Consegnato il 23 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 18 nov 1997 Consegnato il 21 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,620,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 1 x gouet automatic production line comprising 3 x make-up limited, 3 x sogen transfer conveyors, 3 x resting chambers and various other items and goods as listed on the form 395.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 14 nov 1997 Consegnato il 18 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,475,118.98 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Various chattels as specified in agreement no. 355-970448-14 dated 14TH november 1997 between the company and the chargee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 19 mar 1997 Consegnato il 20 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £708,265 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari First fixed charge over:- 1 x jackstone manufacturing line, including 3 spiral coolers, 3 spiral freezers with full interconnecting conveyor system, insulation and controls serial no: A193/14. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 07 mar 1997 Consegnato il 08 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £311,802 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari 1 x abb power factor corrector serial no.C861407/1-5, 32 x artofex stainless steel equipment, 4 x chilled water fan coil units. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 10 dic 1996 Consegnato il 13 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £1,460,285.64 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The items as set out on the schedule attached to form 395 together with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them). Some of the items are one GA18-7.5 Air compressor, 2 40' dry van containers stainless steel, one ADV20-60 and one ADV16-66 condenser and one ADS2-26 and one ADS1-26 dry air cooler. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 15 lug 1996 Consegnato il 20 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £444,520.70 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Various chattels as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 11 lug 1996 Consegnato il 11 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to form 395 being:- one new deltamatic DV50 water meter serial number 6497, one new sprint 300 ri mixer serial number 24999, one new generator serial number CO62137/01. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 09 mag 1996 Consegnato il 11 mag 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £936,432 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage | |
Brevi particolari Various goods comprising 1 x new gouet product line (line number 3). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 02 ott 1995 Consegnato il 04 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £518,495.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage | |
Brevi particolari 1 x microsearch metal detect sys serial number-73734A. 1 x microsearch metal detect sys serial number 73734B. 2 x caseweighers with cintex serial number 2509A.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 01 ago 1995 Consegnato il 02 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £312,406 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Various items of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 26 ago 1993 Consegnato il 07 set 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £40486.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Brevi particolari All right title & interest in & to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral debenture | Creato il 27 nov 1991 Consegnato il 29 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the london superstores limited on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 15 ott 1988 Consegnato il 04 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0