LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED

LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLE PAIN CROUSTILLANT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02116902
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    • Produzione di pane; produzione di prodotti freschi di pasticceria e dolci (10710) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINGATE CATERING LIMITED30 mar 198730 mar 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 set 2012

    Stato del capitale al 26 set 2012

    • Capitale: GBP 1,248
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Nomina di Emmett Mcevoy come amministratore in data 20 apr 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Antony David Smith come amministratore in data 20 apr 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew Mcdonald come amministratore in data 15 nov 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Suzanne Elizabeth Wise come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Avviso di rimozione della restrizione sullo statuto sociale

    2 pagineCC02

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Suzanne Elizabeth Wise il 01 lug 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Simon Nicholas Wilbraham il 01 lug 2011

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Michael Peeler il 01 lug 2011

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Antony David Smith come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Peeler come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mr Simon Nicholas Wilbraham come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    11 pagineAR01

    Cessazione della carica di Robert Lawson come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Segretario
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Segretario
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    Segretario
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    British66183100001
    VANBERGEN, Charles Albert
    The White Cottage Childsbridge Lane
    Seal
    TN15 0BS Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    The White Cottage Childsbridge Lane
    Seal
    TN15 0BS Sevenoaks
    Kent
    British7384900001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Segretario
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Segretario
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Amministratore
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    BARRY, Peter Nigel George
    Hall Farmhouse
    The Street
    NR16 1EZ Ashwellthorpe
    Norfolk
    Amministratore
    Hall Farmhouse
    The Street
    NR16 1EZ Ashwellthorpe
    Norfolk
    EnglandBritish84886660001
    CARTER, Ian Paul
    2 Hedley Gardens
    Hedge End
    SO30 2WT Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    2 Hedley Gardens
    Hedge End
    SO30 2WT Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish79314210001
    CHARTERIS, Derek William
    Belswains Lane
    HP3 9PT Hemel Hempstead
    111
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Belswains Lane
    HP3 9PT Hemel Hempstead
    111
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136986090001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Amministratore
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    DARA, Alireza
    23 Lynwood Road
    W5 1JQ London
    Amministratore
    23 Lynwood Road
    W5 1JQ London
    United KingdomBritish22461240001
    DAVIES, Lyn Theodore
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    Cheridene
    65 Bowham Avenue
    CF31 3PA Bridgend
    Mid Glamorgan
    British34304310003
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Amministratore
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    FORREST, Keith Robert Mckenzie
    18 St Andrews Close
    Moreton On Lugg
    HR4 8DD Hereford
    Hereford & Worcester
    Amministratore
    18 St Andrews Close
    Moreton On Lugg
    HR4 8DD Hereford
    Hereford & Worcester
    British45838740001
    HARRIS, Gareth Addison
    18 Painters Pightle
    Hook
    RG27 9SS Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    18 Painters Pightle
    Hook
    RG27 9SS Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish152131210001
    HOLLOWAY, David John
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    25 Edgar Road
    St Cross
    SO23 9TN Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish66183100001
    HOLROYD, Dean
    51 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    51 Grove Road
    SL4 1JD Windsor
    Berkshire
    British64875220002
    HYDE, Trevor John
    158 Jerounds
    CM19 4HH Harlow
    Essex
    Amministratore
    158 Jerounds
    CM19 4HH Harlow
    Essex
    British71827110001
    JONES, Martin William
    Rose Cottage
    Eathorpe
    CV33 9DE Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    Rose Cottage
    Eathorpe
    CV33 9DE Leamington Spa
    Warwickshire
    British26034610001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Amministratore
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    MALPUS, John James
    Armitage House
    Armitage Road
    WS15 4AZ Armitage
    Staffordshire
    Amministratore
    Armitage House
    Armitage Road
    WS15 4AZ Armitage
    Staffordshire
    British6799180003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Amministratore
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    RELF, Russell Alan
    113 The Chase
    SS6 8QP Rayleigh
    Essex
    Amministratore
    113 The Chase
    SS6 8QP Rayleigh
    Essex
    British59133030001
    RUDDICK, Ian William
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    32 Woodend Drive
    SL5 9BG Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish98350001

    LE PAIN CROUSTILLANT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Borrower deed of charge between the chargors, the issuer, the working capital facility provider, the obligor account banks and the borrower security trustee (each as defined)
    Creato il 28 feb 2001
    Consegnato il 20 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    An amount equal to the borrower secured liabilities defined as all present and future obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the borrower secured creditors (or any of them) under the transaction documents (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of it's respective rights under the transaction documents for which any obligor is liable under the transaction documents on a full indemnity basis.
    Brevi particolari
    All property assets and other rights the subject of the security interests created in favour of the borrower security trustee pursuant to the borrower security documents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank (As Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Creato il 11 set 2000
    Consegnato il 23 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Transazioni
    • 23 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 18 nov 1997
    Consegnato il 21 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,620,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1 x gouet automatic production line comprising 3 x make-up limited, 3 x sogen transfer conveyors, 3 x resting chambers and various other items and goods as listed on the form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 14 nov 1997
    Consegnato il 18 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,475,118.98 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Various chattels as specified in agreement no. 355-970448-14 dated 14TH november 1997 between the company and the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 19 mar 1997
    Consegnato il 20 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £708,265 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First fixed charge over:- 1 x jackstone manufacturing line, including 3 spiral coolers, 3 spiral freezers with full interconnecting conveyor system, insulation and controls serial no: A193/14.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 20 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 07 mar 1997
    Consegnato il 08 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £311,802 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    1 x abb power factor corrector serial no.C861407/1-5, 32 x artofex stainless steel equipment, 4 x chilled water fan coil units. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 10 dic 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,460,285.64 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The items as set out on the schedule attached to form 395 together with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them). Some of the items are one GA18-7.5 Air compressor, 2 40' dry van containers stainless steel, one ADV20-60 and one ADV16-66 condenser and one ADS2-26 and one ADS1-26 dry air cooler. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 15 lug 1996
    Consegnato il 20 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £444,520.70 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Various chattels as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 20 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 11 lug 1996
    Consegnato il 11 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule attached to form 395 being:- one new deltamatic DV50 water meter serial number 6497, one new sprint 300 ri mixer serial number 24999, one new generator serial number CO62137/01. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 11 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 09 mag 1996
    Consegnato il 11 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £936,432 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage
    Brevi particolari
    Various goods comprising 1 x new gouet product line (line number 3). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 02 ott 1995
    Consegnato il 04 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £518,495.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage
    Brevi particolari
    1 x microsearch metal detect sys serial number-73734A. 1 x microsearch metal detect sys serial number 73734B. 2 x caseweighers with cintex serial number 2509A.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 01 ago 1995
    Consegnato il 02 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £312,406 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Various items of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 02 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 26 ago 1993
    Consegnato il 07 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £40486.30 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All right title & interest in & to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 07 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 27 nov 1991
    Consegnato il 29 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the london superstores limited on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 ott 1988
    Consegnato il 04 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0