SPECTATOR LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPECTATOR LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02117658
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPECTATOR LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova SPECTATOR LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPECTATOR LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRIMESIGHT SPECTATOR LIMITED15 dic 198915 dic 1989
    GOKEEN LIMITED31 mar 198731 mar 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPECTATOR LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SPECTATOR LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 feb 2012

    4 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Met Building 22 Percy Street London W1T 2BU England in data 15 mar 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution :- "In Specie"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 mar 2011

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Charlotte House 14 Windmill Street London W1T 2DY in data 27 set 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2010

    Stato del capitale al 04 gen 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Jonathan Daniels il 01 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Naren Anirudha Patel il 01 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Monica Ellen Mackinnon il 01 gen 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di SPECTATOR LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACKINNON, Monica Ellen
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Segretario
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    British107899210001
    DANIELS, Paul Jonathan
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish127121890001
    PATEL, Naren Anirudha
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish44514540003
    CLARK, Peter Ian
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    Segretario
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    New Zealander64941070001
    CLARKE, Sara
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    Segretario
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    British77963580002
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Segretario
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British51065860001
    DESAI, Falguni
    6 Buckleigh Avenue
    SW20 9JZ London
    Segretario
    6 Buckleigh Avenue
    SW20 9JZ London
    British77755390001
    PHILIP, Ian Edward
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    British10317680001
    PINNELL, Judith Helen
    12 Linden Road
    TW12 2JB Hampton
    Middlesex
    Segretario
    12 Linden Road
    TW12 2JB Hampton
    Middlesex
    British127121950001
    TAMES, Jane Elizabeth Anne
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    Segretario
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    British118367070001
    WHITE, Leonard Henry
    19 Montana Road
    SW20 8TW London
    Segretario
    19 Montana Road
    SW20 8TW London
    British12308620001
    DANIELS, Charles James
    Yew Tree End Springwoods
    Wentworth
    GU25 4PW Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Yew Tree End Springwoods
    Wentworth
    GU25 4PW Virginia Water
    Surrey
    British69233900002
    EMSLIE, Donald Gordon
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    Amministratore
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    ScotlandBritish61177720002
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish42787120004
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Amministratore
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritish72256160002
    O'KEEFFE, Daphne Sheila
    120 Woolacombe Road
    Blackheath
    SE3 8QL London
    Amministratore
    120 Woolacombe Road
    Blackheath
    SE3 8QL London
    British22445890001
    PATEL, Naren Anirudha
    33 Verwood Road
    HA2 6LD North Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    33 Verwood Road
    HA2 6LD North Harrow
    Middlesex
    British44514540001
    ROBERTS, David
    295 St Johns Road
    Tunbridge
    TN4 9XE Wells
    Kent
    Amministratore
    295 St Johns Road
    Tunbridge
    TN4 9XE Wells
    Kent
    British107774090001
    WATT, William George
    7 Millar Grove
    ML3 9BF Hamilton
    Amministratore
    7 Millar Grove
    ML3 9BF Hamilton
    ScotlandBritish72664400006
    WOODWARD, Robert Stanley Lawrence
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    Amministratore
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    ScotlandBritish122562020001
    PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED
    14/15 Lower Grosvenor Place
    SW1W 0EX London
    Amministratore
    14/15 Lower Grosvenor Place
    SW1W 0EX London
    54358590001
    PRIMESIGHT NOMINEES LIMITED
    14/15 Lower Grosvenor Place
    SW1W 0EX London
    Amministratore
    14/15 Lower Grosvenor Place
    SW1W 0EX London
    54358850001

    SPECTATOR LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 18 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 02 giu 1997
    Consegnato il 11 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness, liabilities and obligations which are as at 2ND june 1997 or may at any time thereafter be due, owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee, by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Brevi particolari
    First fixed and floating charges over the undertaking and all its property and assets present and future incuding its goodwill and uncalled capital and all plant and machinery. (N.B. the property described in part I and ii of the schedule attached to this form 395 is described as being "none").. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("the Bank")
    Transazioni
    • 11 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 07 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Loan stock trust deed
    Creato il 01 dic 1995
    Consegnato il 05 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the loan stock trust deed including but not limited to payment of the amount of the principal sum then outstanding on the security of the stock and interest on the amount of such principal sum for the time being outstanding at the rate of 10% per year payable half yearly on 31ST december and 30TH june in the years 1996,1997 and 1998 but at 12% per year in 1999 and 14% in 2000.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Botts Capital Nominees Limited(As Trustees)
    • David Martin-Jenkins
    Transazioni
    • 05 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Indemnity and debenture
    Creato il 04 set 1995
    Consegnato il 05 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee in respect of a guarantee dated 4TH september 1995
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Martin Barber
    Transazioni
    • 05 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 dic 1993
    Consegnato il 29 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Primesight Limited
    Transazioni
    • 29 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 nov 1991
    Consegnato il 19 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref 505C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 apr 1991
    Consegnato il 30 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures.).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited.
    Transazioni
    • 30 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SPECTATOR LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 mag 2012Data di scioglimento
    08 mar 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0