P INTERNATIONAL LIMITED

P INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàP INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02117663
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di P INTERNATIONAL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova P INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Marrons Solicitors
    1 Meridian South
    LE19 1WY Meridian Business Park Leicester
    Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di P INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRONTAPRINT INTERNATIONAL LIMITED02 lug 198702 lug 1987
    MUSTERFAIR LIMITED31 mar 198731 mar 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di P INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per P INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 04 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ago 2012

    Stato del capitale al 06 ago 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 ott 2011

    11 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Kevin Arthur Herbert il 04 nov 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 04 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 ott 2010

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Marrons Consultancies Limited il 04 ago 2010

    2 pagineCH04

    Bilancio redatto al 31 ott 2009

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 apr 2007

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine363a

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed prontaprint international limite d\certificate issued on 21/03/07
    2 pagineCERTNM

    legacy

    16 pagine155(6)a

    Bilancio redatto al 30 apr 2006

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    5 pagine288a

    legacy

    5 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di P INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARRONS CONSULTANCIES LIMITED
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01708508
    65475060002
    HERBERT, Kevin Arthur
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    Amministratore
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    EnglandBritishAccountant167011610001
    WHITESIDE, Robert
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    Amministratore
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director81547240001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Segretario
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrishAccountant96288470001
    SPENCE, Michael Allan
    Redlands
    Merrybent
    DL2 2LB Darlington
    County Durham
    Segretario
    Redlands
    Merrybent
    DL2 2LB Darlington
    County Durham
    BritishCompany Director & Chartered M59228100001
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director51120160001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    Amministratore
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrelandIrishAccountant54812330001
    EASTERBY, John William
    59 Clare Avenue
    DL3 8SJ Darlington
    County Durham
    Amministratore
    59 Clare Avenue
    DL3 8SJ Darlington
    County Durham
    BritishCompany Director64275330001
    EVERARD, Clinton Edwin
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director99667360001
    HEATHERINGTON, Paul
    94 Woodlands Road
    Shotley Bridge
    DH8 0DU Consett
    County Durham
    Amministratore
    94 Woodlands Road
    Shotley Bridge
    DH8 0DU Consett
    County Durham
    United KingdomBritishSolicitor40258930001
    LOANE, Beaufort Nelson
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    IrishAccountant78428900001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishAccountant96288470001
    MOTTERSHEAD, Derek Stuart
    The Cottage 1 Millgate
    Gilling West
    DL10 5JQ Richmond
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Cottage 1 Millgate
    Gilling West
    DL10 5JQ Richmond
    North Yorkshire
    BritishCompany Director36334680001
    O TIGHEARNAIGH, Cormac
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant84690240001
    ROSTRON, Kenneth Hutton
    Linden 54 Gilling Road
    DL10 5AN Richmond
    North Yorkshire
    Amministratore
    Linden 54 Gilling Road
    DL10 5AN Richmond
    North Yorkshire
    BritishCompany Director15456990001
    SPENCE, Michael Allan
    Redlands
    Merrybent
    DL2 2LB Darlington
    County Durham
    Amministratore
    Redlands
    Merrybent
    DL2 2LB Darlington
    County Durham
    BritishCompany Director & Chartered M59228100001
    STREET, Geoffrey Graham
    9 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    9 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director70418720001

    P INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 29 nov 1995
    Consegnato il 07 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 lug 1991
    Consegnato il 01 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge on all book & other debts owing to the company. Floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0