BAYLINE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBAYLINE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02118422
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BAYLINE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova BAYLINE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BAYLINE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRIXHAM COACHES LIMITED24 mag 199024 mag 1990
    BAYLINE MINIBUS LIMITED02 dic 198802 dic 1988
    BRIXHAM COACHES LIMITED07 ott 198707 ott 1987
    TRENINGLE LIMITED01 apr 198701 apr 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di BAYLINE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 mag 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per BAYLINE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 18 mag 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    4 pagineMA

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Conto per una società dormiente redatto al 02 mag 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Karen Rosaleen Robbins come amministratore in data 31 mag 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Colin Brown come amministratore in data 31 mag 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Bruce Dingwall come amministratore in data 31 mag 2019

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017

    3 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Stagecoach Devon Limited come persona con controllo significativo il 16 nov 2017

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Stagecoach Services Ltd Daw Bank Stockport Cheshire SK3 0DU a C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road Stockport SK1 3SW in data 16 nov 2017

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Stagecoach Devon Limited come persona con controllo significativo il 16 nov 2017

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BAYLINE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    DINGWALL, Bruce Maxwell
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant185252790001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    EnglandBritishCompany Director73518280001
    BEST, Michael John
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    Segretario
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    British36339320001
    MAYHEW, Graham James
    Langstone House Toadpit Lane
    West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    Segretario
    Langstone House Toadpit Lane
    West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    British2990690001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Segretario
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    BritishFinance Director45931770001
    STOGGELL, Martin Herbert
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    Segretario
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    BritishAccountant27504200001
    STRICKLAND, Annabelle June
    22 Cherry Tree Close
    EX4 5AT Exeter
    Devon
    Segretario
    22 Cherry Tree Close
    EX4 5AT Exeter
    Devon
    British32648300001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    WILDMAN, Lara Joanne
    17 Catalina Close
    Dunkeswell
    EX14 0QD Honiton
    Devon
    Segretario
    17 Catalina Close
    Dunkeswell
    EX14 0QD Honiton
    Devon
    British45772780001
    BEST, Michael John
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    Amministratore
    Harley Thorn Higher Broad Oak Road
    West Hill
    EX11 1XJ Ottery St Mary
    Devon
    BritishFinance Director36339320001
    BLUNDRED, Harold Davies
    Ladram House
    Behind Hayes
    EX9 7JQ Otterton
    Devon
    Amministratore
    Ladram House
    Behind Hayes
    EX9 7JQ Otterton
    Devon
    BritishChairman/Company Director2990700001
    BRAY, David George
    9 Rundle Road
    TQ12 2PJ Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    9 Rundle Road
    TQ12 2PJ Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritishDirector124201200001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant85970020003
    CLARKE, Kenneth Barry
    22 Rosemont Court
    Church Road, Alphington
    EX2 8SY Exeter
    Devon
    Amministratore
    22 Rosemont Court
    Church Road, Alphington
    EX2 8SY Exeter
    Devon
    BritishManaging Director76952760001
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Amministratore
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    BritishFinance Director47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    BritishManager70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Amministratore
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritishExecutive Director1436830002
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Amministratore
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritishFinance Director61722690002
    HILDITCH, Christopher Graham
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    51 Hildene Ampleforth Drive
    The Meadows
    ST17 4TE Stafford
    Staffordshire
    BritishCompany Director10417870001
    JEFFERY, Patricia Janet
    Millburn House
    8 Five Acres
    OX5 2RP Murcott
    Oxfordshire
    Amministratore
    Millburn House
    8 Five Acres
    OX5 2RP Murcott
    Oxfordshire
    BritishCompany Director2990710006
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Chief Executive58643710001
    MACDONALD, Russell Wayne
    Winsham 8 Barton Close
    EX3 0PE Exton
    Devon
    Amministratore
    Winsham 8 Barton Close
    EX3 0PE Exton
    Devon
    BritishManaging Director77122430001
    MAYHEW, Graham James
    Langstone House Toadpit Lane
    West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    Amministratore
    Langstone House Toadpit Lane
    West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    BritishFinancial Director/Company Director2990690001
    MORGAN, Gregory Joseph
    61 Hermitage Road
    Mannamead
    PL3 4RX Plymouth
    Devon
    Amministratore
    61 Hermitage Road
    Mannamead
    PL3 4RX Plymouth
    Devon
    BritishAccountant60817260001
    PALMER, Michael Richard
    14 Courtenay Gardens
    TQ12 1HS Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    14 Courtenay Gardens
    TQ12 1HS Newton Abbot
    Devon
    United KingdomBritishGeneral Manager66314280001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    BritishExecutive Chairman1436810001
    STAITE, John Frederick
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    Amministratore
    30 Byfords Close
    Huntley
    GL19 3SA Gloucester
    United KingdomBritishFinance Director45931770001
    STOGGELL, Martin Herbert
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    Amministratore
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    BritishAccountant27504200001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director49771140004
    WEBB, Clifford
    24 Oakfield Ridge
    EX17 2EG Crediton
    Devon
    Amministratore
    24 Oakfield Ridge
    EX17 2EG Crediton
    Devon
    BritishCompany Director2990720001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BAYLINE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    C/O Stagecoach Services Limited
    United Kingdom
    06 apr 2016
    One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    C/O Stagecoach Services Limited
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03142135
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BAYLINE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 27 set 1996
    Consegnato il 12 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee, the issuing bank and the overdraft bank (both as defined in the deed) (or any of them) under the charge and under the agreement (as defined) and under any of the other finance documents (as defined) and/or any deed or document supplemental thereto
    Brevi particolari
    .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, for Itself and as Agent and Security Trusteefor and on Behalf of the Banks, the Issuing Bank and the Overdraft Bank
    Transazioni
    • 12 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 18 gen 1991
    Consegnato il 25 gen 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stocks shares and/or other securities. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Natwest Investment Bank Limited
    Transazioni
    • 25 gen 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 23 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 giu 1990
    Consegnato il 21 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0