AIM HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | AIM HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 02120855 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AIM HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova AIM HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di AIM HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
AIM LIMITED | 08 mag 1987 | 08 mag 1987 |
EASYCROWN LIMITED | 08 apr 1987 | 08 apr 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di AIM HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 28 feb 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AIM HOLDINGS LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per AIM HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | GAZ2 | |||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2013 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Nomina di Denise Williams come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Ms Vinodka Murria come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kerry Crompton come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Barbara Ann Firth come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Preedy come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul David Gibson come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neal Roberts come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neal Roberts come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* in data 25 mar 2013 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2013 al 28 feb 2013 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Ian Preedy il 15 ago 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Ian Preedy il 16 ago 2012 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Richard Ian Preedy come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Kerry Jane Crompton il 16 mag 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Neal Anthony Roberts il 16 mag 2012 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di AIM HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS, Denise | Segretario | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | British | 176952300001 | ||||||
FIRTH, Barbara Ann | Amministratore | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 73934790009 | ||||
GIBSON, Paul David | Amministratore | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Fcca | 192439290001 | ||||
MURRIA, Vinodka | Amministratore | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Ceo | 57998050002 | ||||
BOOTH, Michael David | Segretario | The Coach House Humber Road HU14 3DW North Ferriby East Yorkshire | British | 88167500001 | ||||||
CHALLINGER, Sara | Segretario | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | Company Secretary | 123713140001 | |||||
FAIREY, Michael Craig | Segretario | 4 Manor Croft Bishop Wilton YO42 1TG York North Yorkshire | British | Finance Director | 113317640001 | |||||
FIRTH, Barbara Ann | Segretario | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | British | Accountant | 73934790001 | |||||
ROBERTS, Neal Anthony | Segretario | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | British | 140194900001 | ||||||
ANDERSON, James Douglas | Amministratore | 4 Stirling Road EH5 3HY Edinburgh | United Kingdom | British | Investment Manager | 15707300001 | ||||
BAGAN, Helen | Amministratore | Flat 4 Spencer Court Spencer Place N1 2AX London | United Kingdom | British | Investment Manager | 102014660001 | ||||
BEARPARK, Richard Mosely | Amministratore | Broadfield 16 Clifford Manor Road GU4 8AG Guildford Surrey | England | British | Chief Executive | 121373650001 | ||||
BOOTH, Michael David | Amministratore | The Coach House Humber Road HU14 3DW North Ferriby East Yorkshire | England | British | Financial Director | 88167500001 | ||||
CROMPTON, Kerry Jane | Amministratore | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | United Kingdom | British | Lawyer | 158261930001 | ||||
DAVIS, John Terence | Amministratore | Greenacres 9 Beverley Road Market Weighton YO4 3JN York North Yorkshire | British | Director | 44635630002 | |||||
FAIREY, Michael Craig | Amministratore | 4 Manor Croft Bishop Wilton YO42 1TG York North Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 113317640001 | ||||
FIRTH, Barbara Ann | Amministratore | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | England | British | Accountant | 73934790001 | ||||
GARTON, Peter Stuart | Amministratore | 11 Church Street Anlaby HU10 7DG Hull North Humberside | British | Director | 36207450001 | |||||
HEWITT, David Dennis | Amministratore | 18 Melton Road North Ferriby HU14 3ET Hull East Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 76597830001 | ||||
HUNT, Peter Charles | Amministratore | 14 The Spinney Swanland HU14 3RD North Ferriby North Humberside | British | Director | 22690310001 | |||||
JEFFREY, John Ewan | Amministratore | 6 Kilmany Road Wormit DD6 8PF Newport On Tay Fife | British | Investment Manager | 23890370001 | |||||
LEUW, Martin Philip | Amministratore | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 141644370001 | ||||
MURRIA, Vinodka | Amministratore | Furran 16 Barham Close KT13 9PR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Partner | 57998050002 | ||||
PREEDY, Richard Ian | Amministratore | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | Accountant | 123433610003 | ||||
RITCHIE, Alastair James | Amministratore | Mickry Lodge 56 Gamekeepers Road EH4 6LS Edinburgh Lothian | British | Company Director | 38770080002 | |||||
ROBERTS, Neal Anthony | Amministratore | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | Director | 12470210004 | ||||
TAYLOR, Keith Edwin | Amministratore | Church View Ivy Lane Hedon HU12 8BL Hull North Humberside | United Kingdom | British | Director | 16866320001 | ||||
VELUSSI, Luca | Amministratore | 123 Hepworth Court 30 Gatliff Road SW1W 8QP London | United Kingdom | Italian | Director | 113413330003 | ||||
WILDE, John Henry | Amministratore | 5 Wilkesley Cottages Wilkesley SY13 4BA Whitchurch | British | Director | 36207460002 |
AIM HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 02 ott 2007 Consegnato il 15 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession and charge | Creato il 19 ott 2006 Consegnato il 02 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Keyman assignation | Creato il 04 lug 1996 Consegnato il 17 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Policy no. 3967240 dated 29TH may 1996 with scottish equitable for the sum of £200,000 on the life of stephen taylor parker together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignation of life policy | Creato il 29 set 1994 Consegnato il 07 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Policy number 3741771 dated 21.3.94 for the sum of £200,000 and all bonuses and benefits and all rights title and interest present and future therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 apr 1994 Consegnato il 17 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to and in terms of the £350,000 10% redeemable secured loan stock 1994 of the company created on 21ST december 1993 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of offset. | Creato il 20 giu 1990 Consegnato il 02 lug 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from aim LTD aim commercial systems LTD, aim supplies and print LTD,aim professional systems LTD training services LTD aim retail systems LTD aim communications services LTD aim law data LTD aim finance LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All sums of the company on any account held by the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 ago 1987 Consegnato il 27 ago 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
AIM HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0