VPPL 2018 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | VPPL 2018 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02121746 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di VPPL 2018 LIMITED?
- Commercio all'ingrosso non specializzato (46900) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova VPPL 2018 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Rsm Restructuring Advisory Llp Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di VPPL 2018 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| VITAL PET PRODUCTS LIMITED | 20 gen 2009 | 20 gen 2009 |
| VITAL DOG SUPPLIES LIMITED | 10 apr 1987 | 10 apr 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di VPPL 2018 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per VPPL 2018 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 15 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 dic 2021 | 15 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 dic 2020 | 16 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dimissioni di un liquidatore | 3 pagine | LIQ06 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 dic 2019 | 25 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ravi Sharma come amministratore in data 30 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2018 al 30 giu 2018 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 3 pagine | NDISC | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 4 pagine | NDISC | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 10 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Sunny Sharma come amministratore in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Barton North Tawton Devon EX20 2BB a Rsm Restructuring Advisory Llp Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 28 nov 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 021217460006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2017 al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 ago 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione di Douglas Osborne Steuart come persona con controllo significativo il 02 mar 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di VPPL 2018 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEUART, Bruce Alexander | Amministratore | Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Rsm Restructuring Advisory Llp | England | British | 108042190002 | |||||
| COOK, Audrey Lucia | Segretario | The Barton North Tawton EX20 2BB Devon | British | 129098600001 | ||||||
| STEUART, Anne Theodosia | Segretario | Smithay Dry Lane EX6 7PE Christow Exeter | British | 15934710001 | ||||||
| ASKEW, Gary Michael | Amministratore | Brook Mill Threadfold Way BL7 9DW Bolton 405 Lancs England | England | British | 65282160003 | |||||
| BOOTH, Anthony | Amministratore | The Barton North Tawton EX20 2BB Devon | England | British | 104996630001 | |||||
| CASELEY, Nigel Paul | Amministratore | 5 Church Close Lapford EX17 6PP Crediton Devon | British | 92687610001 | ||||||
| CHANDLER, David Peter | Amministratore | 13 Vancouver Close BR6 9XQ Orpington Kent | British | 92686880001 | ||||||
| CHANDLER, Luke Thomas | Amministratore | 59 Beverley Road BR2 8QE Bromley Kent | United Kingdom | English | 92424110001 | |||||
| COLYER, Nicholas | Amministratore | Flat 6 54 Old Tiverton Road EX4 6NG Exeter Devon | British | 78705290001 | ||||||
| COOK, Audrey Lucia | Amministratore | Barn Shelley Down St Mary Copplestone EX17 5LG Crediton Devon | British | 44025290002 | ||||||
| COOK, Catherine Anne | Amministratore | Burston Cottage Bow EX17 6LB Crediton Devon | British | 92687880001 | ||||||
| ELSTON, Anthony David | Amministratore | 20 Parkside Gardens BS5 6TZ Bristol Avon | British | 44771430001 | ||||||
| FIRTH, Bruce | Amministratore | The Barton North Tawton EX20 2BB Devon | England | British | 13961170003 | |||||
| JONES, Stephen Robert | Amministratore | 3 Merchants Row Caledonian Road BS1 6JN Bristol | British | 13768830004 | ||||||
| NOLAN, Dermot Fulton | Amministratore | 50 Lewis Crescent Clyst Heath EX2 7DT Exeter Devon | British | 44024870002 | ||||||
| O'CONNELL, Richard James | Amministratore | 21 Fore Street EX20 2DT North Tawton Devon | British | 92687180001 | ||||||
| RICE, Diane Penelope | Amministratore | 1 Moorview EX20 2HW North Tawton Devon | British | 92687500001 | ||||||
| SADDINGTON, Susan Elizabeth | Amministratore | 28 Park Road DT5 2AD Portland Dorset | British | 92422880001 | ||||||
| SAUNDERS, Michael John (Snr) | Amministratore | 24 Kings Meadow Drive EX19 8HD Winkleigh Devon | British | 44025280002 | ||||||
| SAUNDERS JNR, Michael John | Amministratore | 9 The Village Wembworthy EX18 7RZ Chulmleigh Devon | British | 92687780001 | ||||||
| SHARMA, Ravi | Amministratore | Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Rsm Restructuring Advisory Llp | England | British | 230519130001 | |||||
| SHARMA, Sunny | Amministratore | Central Square 5th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Rsm Restructuring Advisory Llp | England | British | 230519140001 | |||||
| SIMONS, Ian Roger | Amministratore | 27 Vixen Tor Close EX20 1TQ Okehampton Devon | British | 92688000001 | ||||||
| STEUART, Alastair Paull | Amministratore | The Barton North Tawton EX20 2BB Devon | United Kingdom | British | 107573140001 | |||||
| STEUART, Alastair Paull | Amministratore | Smithay Dry Lane Christow EX6 7PE Exeter Devon | United Kingdom | British | 107573140001 | |||||
| STEUART, Anne Theodosia | Amministratore | The Barton North Tawton EX20 2BB Devon | England | British | 15934710001 | |||||
| STEUART, Douglas Osborne | Amministratore | The Barton North Tawton EX20 2BB Devon | Thailand | British | 13861850002 | |||||
| YASKIN, Anthony Stephen, Mr | Amministratore | EX20 2BB North Tawton The Barton Devon England | United Kingdom | British | 141873460003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di VPPL 2018 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Sunny Sharma | 02 mar 2017 | The Barton EX20 2BB North Tawton The Barton Devon England | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
| Mrs Anne Theodosia Steuart | 06 apr 2016 | The Barton North Tawton EX20 2BB Devon | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||
Natura del controllo
| |||
| Mr Douglas Osborne Steuart | 06 apr 2016 | The Barton North Tawton EX20 2BB Devon | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: Thailand | |||
Natura del controllo
| |||
VPPL 2018 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 01 mar 2017 Consegnato il 10 mar 2017 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 20 ott 2011 Consegnato il 28 ott 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 31 ott 2007 Consegnato il 09 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 20 mag 1999 Consegnato il 27 mag 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 04 ago 1994 Consegnato il 06 ago 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 21 lug 1987 Consegnato il 24 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
VPPL 2018 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0