KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED

KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02122159
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 New Street Square
    EC4A 3TW London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FIRST GRESHAM PENSION FUND LIMITED10 apr 198710 apr 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Charles Phillips come amministratore in data 31 dic 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 dic 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Duncan James Langlands Abbot come segretario in data 24 giu 2016

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Gary Cresswell come segretario in data 24 giu 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Duncan James Langlands Abbot come amministratore in data 24 giu 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Kevin John Acton come amministratore in data 24 giu 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 05 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 dic 2015

    Stato del capitale al 07 dic 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 dic 2014

    Stato del capitale al 08 dic 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 235 Hunts Pond Road Fareham Hampshire PO14 4PJ

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 235 Hunts Pond Road Fareham Hampshire PO14 4PJ

    1 pagineAD02

    Nomina di Mr Anthony Lionel Dalwood come amministratore in data 01 dic 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRESSWELL, Gary
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    Segretario
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    209435460001
    ACTON, Kevin John
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    Amministratore
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United KingdomBritishFinance Director208796890001
    DALWOOD, Anthony Lionel
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Amministratore
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    EnglandBritishCompany Director75474370002
    ABBOT, Duncan James Langlands
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Segretario
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    193210070001
    CLARK, Karen Ann
    36 Elder Street
    E1 6BT London
    Segretario
    36 Elder Street
    E1 6BT London
    British32471330001
    HALLETT, Brian James
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Segretario
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Other134379970001
    ABBOT, Duncan James Langlands
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Amministratore
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    EnglandBritishCompany Director76940730002
    BOYENS, Michael
    17 Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    17 Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritishDirector12791090003
    CHADWICK, Richard Andrew
    Floor
    17 Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th
    England
    Amministratore
    Floor
    17 Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th
    England
    EnglandBritishAccountant23417870001
    EARLEY, Fintan Michael
    Apartment C24
    15 Boulevard De La Liberation
    St Jean
    Cap Ferrat
    France
    Amministratore
    Apartment C24
    15 Boulevard De La Liberation
    St Jean
    Cap Ferrat
    France
    IrishDirector77582070001
    HALLETT, Brian James
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Amministratore
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    EnglandBritishDirector9715270002
    LORIMER, John Anthony Crosbie
    17 Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    17 Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritishProperty Director8674270004
    LUCIE-SMITH, Derek
    17 Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    17 Grosvenor Gardens
    SW1W 0BD London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant60313780001
    PHILLIPS, Michael Charles
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Amministratore
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    EnglandBritishCompany Director98899790001
    STIRLING, Alfred Patrick
    36 Elder Street
    E1 6BT London
    Amministratore
    36 Elder Street
    E1 6BT London
    United KingdomBritishDirector6373230001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    New Capital Holdings Limited
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    06 apr 2016
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House - England
    Numero di registrazione01112245
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    KNOWSLEY INDUSTRIAL PROPERTY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 03 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 4 deacon estate hornhouse lane knowsley industrial park liverpool; t/no MS475977. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge of deposit
    Creato il 22 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 20671189 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment and charge
    Creato il 18 lug 2003
    Consegnato il 31 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title benefit and interest to and in all money payable to or to the account of the company under or pursuant to an agreement for lease dated 1 may 2003. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 lug 2003
    Consegnato il 31 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 4 deacon park, knowsley, merseyside. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0