HML MARKETING LIMITED

HML MARKETING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHML MARKETING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02123255
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HML MARKETING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HML MARKETING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    52 - 54 Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HML MARKETING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOLMAN MARKETING LIMITED05 mar 199905 mar 1999
    CHARLESWORTH & COX LIMITED22 lug 198722 lug 1987
    CULTSTEADY LIMITED15 apr 198715 apr 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di HML MARKETING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per HML MARKETING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Nomina di Mr David Charles Turner come segretario in data 14 lug 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di James David Seton Adams come segretario in data 14 lug 2017

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2016

    Stato del capitale al 18 mag 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Mr James David Seton Adams come segretario in data 07 dic 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Steven Terence Hunter Griffin come segretario in data 30 set 2015

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Library House, New Road Brentwood Essex CM14 4GD a 52 - 54 Leadenhall Street London EC3A 2BJ in data 16 lug 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 mag 2015

    Stato del capitale al 13 mag 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Victoria Louise Cuggy come segretario in data 01 mag 2015

    1 pagineTM02

    Stato del capitale al 31 dic 2014

    • Capitale: GBP 100
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mag 2014

    Stato del capitale al 15 mag 2014

    • Capitale: GBP 1,053,670
    SH01

    Nomina di Mr Steven Terence Hunter Griffin come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Katharine Anne Wade il 23 dic 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Mrs Katharine Anne Wade come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Gibson come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di HML MARKETING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TURNER, David Charles
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Segretario
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    236362940001
    PARKER, Ian David
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Amministratore
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    United KingdomBritish165728150001
    WADE, Katharine Anne
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Amministratore
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    EnglandBritish152543610003
    ADAMS, James David Seton
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Segretario
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    203469030001
    CUGGY, Victoria Louise
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    Segretario
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    British105782010002
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Segretario
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    186666670001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    Segretario
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    British85213650001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    21 Burrow Road
    SE22 8DU London
    Segretario
    21 Burrow Road
    SE22 8DU London
    British63143680001
    MITCHINSON, John Frederick
    Riseholme Western Road
    BN27 3DY Hailsham
    East Sussex
    Segretario
    Riseholme Western Road
    BN27 3DY Hailsham
    East Sussex
    English15466150001
    RINGROSE, Christopher James
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    Segretario
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    British46372950001
    ROSSER, Jill Rowena
    8 Belgrade Road
    TW12 2AZ Hampton
    Middlesex
    Segretario
    8 Belgrade Road
    TW12 2AZ Hampton
    Middlesex
    British27339680002
    BOOT, Rodney Frederick
    9 Crafton Close
    George Green
    Slough
    Berkshire
    Amministratore
    9 Crafton Close
    George Green
    Slough
    Berkshire
    British5162470001
    BROWN, Deryck Justin
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    Amministratore
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    United KingdomBritish123356160001
    CHARLES, Colin David
    The Holt 48 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    Amministratore
    The Holt 48 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    EnglandBritish46667150002
    COULTHARD, David John De Marle
    4 Phillimore Place
    W8 7BU London
    Amministratore
    4 Phillimore Place
    W8 7BU London
    United KingdomBritish5343780001
    COX, Stephen Anthony
    68 St Georges Square
    SW1V 3QT London
    Amministratore
    68 St Georges Square
    SW1V 3QT London
    British14016820001
    CUGGY, Victoria Louise
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    Amministratore
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    United KingdomBritish105782010002
    DODDS, Paul Gavin
    Badgers Barn
    Sparrow Lane
    CM22 7BA Hatfield Broad Oak
    Hertfordshire
    Amministratore
    Badgers Barn
    Sparrow Lane
    CM22 7BA Hatfield Broad Oak
    Hertfordshire
    EnglandBritish160890670001
    FRIEND, Gary
    14 Pyefleet View
    Langenhoe
    CO5 7LD Colchester
    Essex
    Amministratore
    14 Pyefleet View
    Langenhoe
    CO5 7LD Colchester
    Essex
    British98993810002
    GIBSON, Andrew James
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    Amministratore
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    EnglandBritish51599670003
    INGLIS, Robert John
    35 Marine Parade
    SS9 2NB Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    35 Marine Parade
    SS9 2NB Leigh On Sea
    Essex
    British64257020001
    MITCHINSON, John Frederick
    Riseholme Western Road
    BN27 3DY Hailsham
    East Sussex
    Amministratore
    Riseholme Western Road
    BN27 3DY Hailsham
    East Sussex
    English15466150001
    MOWL, Donald William
    4 Ridgeway
    CM12 9NT Billericay
    Essex
    Amministratore
    4 Ridgeway
    CM12 9NT Billericay
    Essex
    British2850940001
    POTTS, Nicholas
    4 Ringstone
    Kromlin Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    Amministratore
    4 Ringstone
    Kromlin Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    EnglandBritish64059360004
    POTTS, Nicholas
    4 Ringstone
    Kromlin Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    Amministratore
    4 Ringstone
    Kromlin Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    EnglandBritish64059360004
    REILLY, Charles Andrew
    Tree Tops
    Woodlands Lane Shorne
    DA12 3HH Gravesend
    Kent
    Amministratore
    Tree Tops
    Woodlands Lane Shorne
    DA12 3HH Gravesend
    Kent
    United KingdomBritish64256990003
    SPRIGGS, Jane Louisa
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    Amministratore
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    United KingdomBritish138176700001
    SUTHERLAND, Ian Ronald
    85 The Waterfront
    Mill Road
    SG14 1SD Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    85 The Waterfront
    Mill Road
    SG14 1SD Hertford
    Hertfordshire
    British98993590002
    UTLEY, Neil Alan
    Larkins Farm
    199 Nine Ashes Road
    CM4 0JY Blackmore
    Essex
    Amministratore
    Larkins Farm
    199 Nine Ashes Road
    CM4 0JY Blackmore
    Essex
    United Arab EmiratesBritish161350430001
    WHITFIELD, Michael Peter
    Roughstone Hall Farm
    Bradnop
    ST13 7NN Leek
    Staffordshire
    Amministratore
    Roughstone Hall Farm
    Bradnop
    ST13 7NN Leek
    Staffordshire
    EnglandBritish69571090002
    WILLS, Richard Frederick De Leigh
    Lollesworth Farm
    KT24 6HN West Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Lollesworth Farm
    KT24 6HN West Horsley
    Surrey
    EnglandBritish13952230001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HML MARKETING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52-54
    England
    06 apr 2016
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52-54
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleLaw Of England And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02925652
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HML MARKETING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 13 ott 2004
    Consegnato il 27 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the real property the accounts the insurance policies the proceeds thereof and all related rights the intellectual property any goodwill by way of floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee)
    Transazioni
    • 27 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 mag 2002
    Consegnato il 31 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (As Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 31 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A subordination and security trust deed dated 25 april 2002 made between the company and the obligors listed in schedule 3 to this form 395 (the "original obligors), hsbc investment bank PLC (the "trustee" and "agent") and the lenders listed in schedule 4 to this form 395 (the "orignal lenders").
    Creato il 25 apr 2002
    Consegnato il 07 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities now or at any time in the future due, owing or incurred by the obligors to secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company has covenanted and agreed that in the event of payment or discharge (whether in cash, by way of transfer of shares or other assets, set-off or counterclaim or otherwise) being made to, or an encumbrance being held by, the company in breach of clause 3.2 (prohibited payments and security) of the subordination and security trust deed, it will pay or transfer to the trustee for application in accordance with the terms of clause 7 (application of proceeds) of the subordination and security trust deed any sums or other assets which shall have been received or retained by it in consequence of such breach (whereupon the underlying subordination debt equivalent to the payment made shall be deemed not to have been reduced) and, until such payment or transfer, the company shall hold such sums or other assets or such encumbrance (as the case may be) on trust for the trustee.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank Plcas Agent and Trustee for the Secured Parties Under the Subordination and Security Trust Deed
    Transazioni
    • 07 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0