HML MARKETING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HML MARKETING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02123255 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HML MARKETING LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova HML MARKETING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 52 - 54 Leadenhall Street EC3A 2BJ London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HML MARKETING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HOLMAN MARKETING LIMITED | 05 mar 1999 | 05 mar 1999 |
| CHARLESWORTH & COX LIMITED | 22 lug 1987 | 22 lug 1987 |
| CULTSTEADY LIMITED | 15 apr 1987 | 15 apr 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HML MARKETING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per HML MARKETING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Charles Turner come segretario in data 14 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di James David Seton Adams come segretario in data 14 lug 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr James David Seton Adams come segretario in data 07 dic 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Terence Hunter Griffin come segretario in data 30 set 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Library House, New Road Brentwood Essex CM14 4GD a 52 - 54 Leadenhall Street London EC3A 2BJ in data 16 lug 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Victoria Louise Cuggy come segretario in data 01 mag 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Stato del capitale al 31 dic 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Steven Terence Hunter Griffin come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Katharine Anne Wade il 23 dic 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Katharine Anne Wade come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Gibson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HML MARKETING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURNER, David Charles | Segretario | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | 236362940001 | |||||||
| PARKER, Ian David | Amministratore | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | United Kingdom | British | 165728150001 | |||||
| WADE, Katharine Anne | Amministratore | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | England | British | 152543610003 | |||||
| ADAMS, James David Seton | Segretario | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | 203469030001 | |||||||
| CUGGY, Victoria Louise | Segretario | Library House, New Road Brentwood CM14 4GD Essex | British | 105782010002 | ||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Segretario | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | 186666670001 | |||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Segretario | Holliwell Chandlers CM0 8NY Burnham On Crouch Essex | British | 85213650001 | ||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Segretario | 21 Burrow Road SE22 8DU London | British | 63143680001 | ||||||
| MITCHINSON, John Frederick | Segretario | Riseholme Western Road BN27 3DY Hailsham East Sussex | English | 15466150001 | ||||||
| RINGROSE, Christopher James | Segretario | Lindum Lodge, Orchard Close Risby IP28 6QL Bury St Edmunds Suffolk | British | 46372950001 | ||||||
| ROSSER, Jill Rowena | Segretario | 8 Belgrade Road TW12 2AZ Hampton Middlesex | British | 27339680002 | ||||||
| BOOT, Rodney Frederick | Amministratore | 9 Crafton Close George Green Slough Berkshire | British | 5162470001 | ||||||
| BROWN, Deryck Justin | Amministratore | Library House, New Road Brentwood CM14 4GD Essex | United Kingdom | British | 123356160001 | |||||
| CHARLES, Colin David | Amministratore | The Holt 48 Woodcote Avenue SM6 0QY Wallington Surrey | England | British | 46667150002 | |||||
| COULTHARD, David John De Marle | Amministratore | 4 Phillimore Place W8 7BU London | United Kingdom | British | 5343780001 | |||||
| COX, Stephen Anthony | Amministratore | 68 St Georges Square SW1V 3QT London | British | 14016820001 | ||||||
| CUGGY, Victoria Louise | Amministratore | Library House, New Road Brentwood CM14 4GD Essex | United Kingdom | British | 105782010002 | |||||
| DODDS, Paul Gavin | Amministratore | Badgers Barn Sparrow Lane CM22 7BA Hatfield Broad Oak Hertfordshire | England | British | 160890670001 | |||||
| FRIEND, Gary | Amministratore | 14 Pyefleet View Langenhoe CO5 7LD Colchester Essex | British | 98993810002 | ||||||
| GIBSON, Andrew James | Amministratore | New Road CM14 4GD Brentwood Library House Essex | England | British | 51599670003 | |||||
| INGLIS, Robert John | Amministratore | 35 Marine Parade SS9 2NB Leigh On Sea Essex | British | 64257020001 | ||||||
| MITCHINSON, John Frederick | Amministratore | Riseholme Western Road BN27 3DY Hailsham East Sussex | English | 15466150001 | ||||||
| MOWL, Donald William | Amministratore | 4 Ridgeway CM12 9NT Billericay Essex | British | 2850940001 | ||||||
| POTTS, Nicholas | Amministratore | 4 Ringstone Kromlin Barkisland HX4 0EU Halifax | England | British | 64059360004 | |||||
| POTTS, Nicholas | Amministratore | 4 Ringstone Kromlin Barkisland HX4 0EU Halifax | England | British | 64059360004 | |||||
| REILLY, Charles Andrew | Amministratore | Tree Tops Woodlands Lane Shorne DA12 3HH Gravesend Kent | United Kingdom | British | 64256990003 | |||||
| SPRIGGS, Jane Louisa | Amministratore | Library House, New Road Brentwood CM14 4GD Essex | United Kingdom | British | 138176700001 | |||||
| SUTHERLAND, Ian Ronald | Amministratore | 85 The Waterfront Mill Road SG14 1SD Hertford Hertfordshire | British | 98993590002 | ||||||
| UTLEY, Neil Alan | Amministratore | Larkins Farm 199 Nine Ashes Road CM4 0JY Blackmore Essex | United Arab Emirates | British | 161350430001 | |||||
| WHITFIELD, Michael Peter | Amministratore | Roughstone Hall Farm Bradnop ST13 7NN Leek Staffordshire | England | British | 69571090002 | |||||
| WILLS, Richard Frederick De Leigh | Amministratore | Lollesworth Farm KT24 6HN West Horsley Surrey | England | British | 13952230001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HML MARKETING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ers Insurance Group Limited | 06 apr 2016 | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52-54 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HML MARKETING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 13 ott 2004 Consegnato il 27 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of fixed charge the real property the accounts the insurance policies the proceeds thereof and all related rights the intellectual property any goodwill by way of floating charge the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 mag 2002 Consegnato il 31 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A subordination and security trust deed dated 25 april 2002 made between the company and the obligors listed in schedule 3 to this form 395 (the "original obligors), hsbc investment bank PLC (the "trustee" and "agent") and the lenders listed in schedule 4 to this form 395 (the "orignal lenders"). | Creato il 25 apr 2002 Consegnato il 07 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities now or at any time in the future due, owing or incurred by the obligors to secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company has covenanted and agreed that in the event of payment or discharge (whether in cash, by way of transfer of shares or other assets, set-off or counterclaim or otherwise) being made to, or an encumbrance being held by, the company in breach of clause 3.2 (prohibited payments and security) of the subordination and security trust deed, it will pay or transfer to the trustee for application in accordance with the terms of clause 7 (application of proceeds) of the subordination and security trust deed any sums or other assets which shall have been received or retained by it in consequence of such breach (whereupon the underlying subordination debt equivalent to the payment made shall be deemed not to have been reduced) and, until such payment or transfer, the company shall hold such sums or other assets or such encumbrance (as the case may be) on trust for the trustee.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0