BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02125426 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O MAZARS LLP 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT a 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 22 apr 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a Lodge Way House Lodge Way Harleston Road Northampton NN5 7UG | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG United Kingdom a 45 Church Street Birmingham B3 2RT in data 23 dic 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Notifica di Travis Perkins Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione di Gammon & Smith Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 12 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2019 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 1 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Gammon & Smith Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Nigel Hampden Smith come amministratore in data 20 feb 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey Ian Cooper come amministratore in data 01 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Stephen Pike come segretario in data 01 ago 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Tp Directors Ltd come amministratore in data 20 set 2018 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 45 Church Street Birmingham B3 2RT a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG in data 23 nov 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Alan Richard | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 137582690004 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Amministratore | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| BACON, Timothy Reginald | Segretario | 1 Wendover Gardens Christchurch GL50 2PA Cheltenham Gloucestershire | British | 11336800001 | ||||||||||
| BARNETT, Graham Philip | Segretario | 67 Lone Pine Drive West Parley BH22 8LR Ferndown Dorset | British | 14644360002 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Segretario | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | 65678800002 | ||||||||||
| VALE, Ronald Edward | Segretario | 10 Greensleeves Avenue BH18 8BL Broadstone Dorset | British | 39756870001 | ||||||||||
| BACON, Timothy Reginald | Amministratore | 1 Wendover Gardens Christchurch GL50 2PA Cheltenham Gloucestershire | British | 11336800001 | ||||||||||
| BARNETT, Graham Philip | Amministratore | 67 Lone Pine Drive West Parley BH22 8LR Ferndown Dorset | British | 14644360002 | ||||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Amministratore | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| FISHER, Charles Murray | Amministratore | Warneford House Sudgrove GL6 7JD Miserden Gloucestershire | United Kingdom | British | 74765660002 | |||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Amministratore | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| MCKAY, Francis John | Amministratore | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | British | 78787530001 | ||||||||||
| ROPER, Bernard David | Amministratore | 17 Charlton Drive Charlton Kings GL53 8ES Cheltenham Gloucestershire | England | British | 11336810001 | |||||||||
| TRUMAN, John | Amministratore | Vales Oasis Alfred Street DT11 7JN Blandford Forum Dorset | United Kingdom | British | 39863480001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gammon & Smith Limited | 06 apr 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Travis Perkins Plc | 06 apr 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 06 gen 1997 Consegnato il 08 gen 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 20 ott 1994 Consegnato il 27 ott 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 3 july 1987 | |
Brevi particolari Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge registered pursuant to an order of court dated 30/7/90 | Creato il 15 mag 1990 Consegnato il 03 ago 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a unit 2 sunrise business park blandford forum dorset. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 03 lug 1987 Consegnato il 14 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
BLANDFORD BUILDERS & DECORATORS MERCHANTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0