ARRIVA CHESHIRE LIMITED

ARRIVA CHESHIRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARRIVA CHESHIRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02127702
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARRIVA CHESHIRE LIMITED?

    • Altri trasporti passeggeri urbani, suburbani o metropolitani via terra (non metropolitana o sistemi simili) (49319) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova ARRIVA CHESHIRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARRIVA CHESHIRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARROWLINE (TRAVEL) LIMITED05 mag 198705 mag 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARRIVA CHESHIRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per ARRIVA CHESHIRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP in data 14 set 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore in data 28 ago 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip Martin Stone come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 gen 2012

    Stato del capitale al 03 gen 2012

    • Capitale: GBP 27,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Malcolm Gilkerson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Malcolm Gilkerson il 05 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 05 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Martin Stone il 05 gen 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 05 gen 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di ARRIVA CHESHIRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    Segretario
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Amministratore
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritish161250030001
    FAWCETT, Pauline
    Oaklands Warrington Road
    Mere
    WA16 0TF Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    Oaklands Warrington Road
    Mere
    WA16 0TF Knutsford
    Cheshire
    British4159290001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    54 Endless Street
    SP1 3UH Salisbury
    Wiltshire
    42985760001
    BAYFIELD, Stephen
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Windy Ridge Riverside Close
    Stoford
    SP2 0PX Salisbury
    Wiltshire
    British42058550001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish35116070001
    CLAYTON, Stephen John
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish46866840005
    FAWCETT, Simon Anthony
    Blair House Legh Road
    WA16 8LP Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Blair House Legh Road
    WA16 8LP Knutsford
    Cheshire
    British7273070001
    GILKERSON, Malcolm
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish46793270001
    HIND, Robert Andrew
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish21961900002
    JONES, Michael Adrian
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    3 Old Shaftesbury Drive
    Old Blandford Road Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish77984700001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    RAVEN, Garry Stuart
    38 Daleside
    Thornhill Edge
    WF12 0PJ Dewsbury
    West Yorkshire
    Amministratore
    38 Daleside
    Thornhill Edge
    WF12 0PJ Dewsbury
    West Yorkshire
    British64406500001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    STONE, Philip Martin
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritish69200640003
    STONE, Philip Martin
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Amministratore
    21 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish69200640003
    WALLACE, Neale Howard
    17 Lincoln Road
    Wrockwardine Wood
    TF2 6LF Telford
    Shropshire
    Amministratore
    17 Lincoln Road
    Wrockwardine Wood
    TF2 6LF Telford
    Shropshire
    British43081660001
    WATT, Gordon George
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Alderbury Holt
    Southampton Road,Clarendon
    SP5 3DG Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish67622780002
    WILLIAMS, Dawson Thomas
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Chately Wood House
    Rockford
    BH24 3LZ Ringwood
    Hampshire
    British2719600006

    ARRIVA CHESHIRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement,any interest rate agreement or any other grant or security under any of the security documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston("the Agent") as Agent and Trustee for Each of the Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 25 mag 1993
    Consegnato il 03 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £71,365.02 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the paper apart to form 395 see form 395 M139C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 03 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 18 gen 1993
    Consegnato il 19 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and as described 1 new mercedes benz 709D chassis cab fitted with dormobile body chassis no:669003-2N-0048165,registration no:K880 udb or any part thereof.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 19 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 lug 1987
    Consegnato il 15 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ARRIVA CHESHIRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0