ARRIVA CHESHIRE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ARRIVA CHESHIRE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02127702 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ARRIVA CHESHIRE LIMITED?
- Altri trasporti passeggeri urbani, suburbani o metropolitani via terra (non metropolitana o sistemi simili) (49319) / Trasporto e stoccaggio
Dove si trova ARRIVA CHESHIRE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ARRIVA CHESHIRE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ARROWLINE (TRAVEL) LIMITED | 05 mag 1987 | 05 mag 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ARRIVA CHESHIRE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per ARRIVA CHESHIRE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 9 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP in data 14 set 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore in data 28 ago 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip Martin Stone come amministratore in data 28 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Anthony Bowler come amministratore in data 28 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm Gilkerson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Malcolm Gilkerson il 05 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Richard Anthony Bowler il 05 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Martin Stone il 05 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 05 gen 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2008 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2007 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ARRIVA CHESHIRE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Segretario | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Amministratore | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village | England | British | 161250030001 | |||||
| FAWCETT, Pauline | Segretario | Oaklands Warrington Road Mere WA16 0TF Knutsford Cheshire | British | 4159290001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Segretario | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| BRITISH BUS (COMPANY SECRETARIES) LIMITED | Segretario | 54 Endless Street SP1 3UH Salisbury Wiltshire | 42985760001 | |||||||
| BAYFIELD, Stephen | Amministratore | Windy Ridge Riverside Close Stoford SP2 0PX Salisbury Wiltshire | British | 42058550001 | ||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| CLAYTON, Stephen John | Amministratore | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | 46866840005 | |||||
| FAWCETT, Simon Anthony | Amministratore | Blair House Legh Road WA16 8LP Knutsford Cheshire | British | 7273070001 | ||||||
| GILKERSON, Malcolm | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | United Kingdom | British | 46793270001 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Amministratore | 18 Maplewell Road Woodhouse Eaves LE12 8QZ Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 21961900002 | |||||
| JONES, Michael Adrian | Amministratore | 3 Old Shaftesbury Drive Old Blandford Road Harnham SP2 8QH Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 77984700001 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Amministratore | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Amministratore | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| RAVEN, Garry Stuart | Amministratore | 38 Daleside Thornhill Edge WF12 0PJ Dewsbury West Yorkshire | British | 64406500001 | ||||||
| RAY, John Alfred | Amministratore | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| STONE, Philip Martin | Amministratore | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne And Wear | England | British | 69200640003 | |||||
| STONE, Philip Martin | Amministratore | 21 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | 69200640003 | |||||
| WALLACE, Neale Howard | Amministratore | 17 Lincoln Road Wrockwardine Wood TF2 6LF Telford Shropshire | British | 43081660001 | ||||||
| WATT, Gordon George | Amministratore | Alderbury Holt Southampton Road,Clarendon SP5 3DG Salisbury Wiltshire | England | British | 67622780002 | |||||
| WILLIAMS, Dawson Thomas | Amministratore | Chately Wood House Rockford BH24 3LZ Ringwood Hampshire | British | 2719600006 |
ARRIVA CHESHIRE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Creato il 15 giu 1995 Consegnato il 20 giu 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the loan agreement,any interest rate agreement or any other grant or security under any of the security documents (as defined therein) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Credit agreement | Creato il 25 mag 1993 Consegnato il 03 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £71,365.02 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the paper apart to form 395 see form 395 M139C for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattels mortgage | Creato il 18 gen 1993 Consegnato il 19 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and singular the chattels plant machinery and as described 1 new mercedes benz 709D chassis cab fitted with dormobile body chassis no:669003-2N-0048165,registration no:K880 udb or any part thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 lug 1987 Consegnato il 15 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ARRIVA CHESHIRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0