20TWENTY INDEPENDENT LIMITED

20TWENTY INDEPENDENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società20TWENTY INDEPENDENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02129037
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 20TWENTY INDEPENDENT LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova 20TWENTY INDEPENDENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    37 Sun Street
    EC2M 2PL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 20TWENTY INDEPENDENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CITY INDEPENDENT INTERMEDIARIES LIMITED03 feb 199903 feb 1999
    TWENTY TWENTY INDEPENDENT LIMITED05 gen 199905 gen 1999
    TWENTY TWENTY INDEPENDENT INTERMEDIARIES LIMITED17 dic 199817 dic 1998
    CITY INDEPENDENT INTERMEDIARIES LIMITED24 set 199824 set 1998
    CITY FINANCIAL INDEPENDENT INTERMEDIARIES LIMITED06 nov 199206 nov 1992
    THE CITY FINANCIAL INDEPENDENT INTERMEDIARIES COMPANY LIMITED13 feb 199213 feb 1992
    THE M.I. INDEPENDENT INTERMEDIARIES COMPANY LIMITED21 mar 198821 mar 1988
    THE M.I. AGENCY COMPANY LIMITED 01 ott 198701 ott 1987
    LEGIBUS 927 LIMITED07 mag 198707 mag 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di 20TWENTY INDEPENDENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per 20TWENTY INDEPENDENT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per 20TWENTY INDEPENDENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 ott 2014

    16 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * 34 Ely Place London EC1N 6TD* in data 22 apr 2014

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 50 Farringdon Road London EC1M 3HE England* in data 14 nov 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 giu 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 gen 2013

    Stato del capitale al 17 gen 2013

    • Capitale: GBP 570,000
    SH01

    Cessazione della carica di Hazel Carter come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Christopher Deacon come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neil Blackburn come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Clerkenwell House 67 Clerkenwell Road London EC1R 5BL* in data 24 mag 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Neil Peter Blackburn come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher Deacon il 02 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Vincenzo Antonio De Stefano il 02 dic 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2008

    12 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di 20TWENTY INDEPENDENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DE STEFANO, Vincenzo Antonio
    Sun Street
    EC2M 2PL London
    37
    Amministratore
    Sun Street
    EC2M 2PL London
    37
    SpainItalian93462290004
    CARTER, Hazel Ward
    32 Cloisters Avenue
    BR2 8AW Bickley
    Kent
    Segretario
    32 Cloisters Avenue
    BR2 8AW Bickley
    Kent
    British80247680001
    DEACON, Christopher
    The Old Post Office
    Hinton Parva
    SN4 0DH Swindon
    Wiltshire
    Segretario
    The Old Post Office
    Hinton Parva
    SN4 0DH Swindon
    Wiltshire
    British80649240001
    GORDON, Simon
    33 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    33 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    British20418520001
    BLACKBURN, Neil Peter
    Farringdon Road
    EC1M 3HE London
    50
    England
    Amministratore
    Farringdon Road
    EC1M 3HE London
    50
    England
    EnglandBritish155335010001
    DEACON, Christopher
    Farringdon Road
    EC1M 3HE London
    50
    England
    Amministratore
    Farringdon Road
    EC1M 3HE London
    50
    England
    EnglandBritish80649240001
    FANNING, Christopher Peter
    2 Hatters Court
    Redcross Way
    SE1 1EB London
    Amministratore
    2 Hatters Court
    Redcross Way
    SE1 1EB London
    British73905680001
    FOLLAND, Alexander Guy
    Oaklands Cadbury Camp Lane
    Clapton In Gordano
    BS20 9SB Bristol
    Amministratore
    Oaklands Cadbury Camp Lane
    Clapton In Gordano
    BS20 9SB Bristol
    British72528920001
    GEORGE, Peter Richard
    4 Charlotte Street
    BA1 2NE Bath
    Avon
    Amministratore
    4 Charlotte Street
    BA1 2NE Bath
    Avon
    British1894170001
    GEORGE, Peter Richard
    4 Charlotte Street
    BA1 2NE Bath
    Avon
    Amministratore
    4 Charlotte Street
    BA1 2NE Bath
    Avon
    British1894170001
    GORDON, Simon
    33 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    33 Newberries Avenue
    WD7 7EJ Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish20418520001
    INGRAM, Simon Jonathan Joseph
    High Banks Carrington Close
    Coombe Park Kingston Hill
    KT2 7JB Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    High Banks Carrington Close
    Coombe Park Kingston Hill
    KT2 7JB Kingston Upon Thames
    Surrey
    British72480590003
    JOHNSON, Robin Hardy
    Rose Cottage
    Dixter Road
    TN31 6LB Northiam
    East Sussex
    Amministratore
    Rose Cottage
    Dixter Road
    TN31 6LB Northiam
    East Sussex
    British70680910002
    MARTIN, Mark Stephen, Dr
    School Lane
    TN15 6AL West Kingsdown
    Earlylands
    Kent
    Amministratore
    School Lane
    TN15 6AL West Kingsdown
    Earlylands
    Kent
    United KingdomBritish121469750002
    MORRISON, Raymond Stuart
    9 Martingales Close
    Ham Common
    TW10 7JJ Richmond
    Surrey
    Amministratore
    9 Martingales Close
    Ham Common
    TW10 7JJ Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish73111970001
    ROGERS, Derek John
    Woodlands High Street
    Wanborough
    SN4 0AE Swindon
    Wiltshire
    Amministratore
    Woodlands High Street
    Wanborough
    SN4 0AE Swindon
    Wiltshire
    British51815620001
    SEXTON, Mark Andrew
    7 Crerar Close
    GU14 0PZ Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    7 Crerar Close
    GU14 0PZ Farnborough
    Hampshire
    British67124780001

    20TWENTY INDEPENDENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 18 ott 2006
    Consegnato il 31 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re 20TWENTY independent limited.business tracker account.account number 80457116. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 ago 2002
    Consegnato il 20 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Ground and lower ground floors (west) clerkenwell house 67 clerkenwell road london.
    Persone aventi diritto
    • Clerkenwell House (1987) Limited
    Transazioni
    • 20 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 apr 1990
    Consegnato il 20 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a guarantee dated 6/4/90
    Brevi particolari
    (See 395 ref M336 and cont'd sheets for full details of charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Wimpole Street Investments Limited
    Transazioni
    • 20 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mar 1990
    Consegnato il 12 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cornhill Insurance Public Limited Company.
    Transazioni
    • 12 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 24 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 giu 1989
    Consegnato il 17 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £3,000,000 and all other moneys due or to become due from the M.I. group limited to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Stock in trade, work-in-progress. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cornhill Insurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 17 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 14 mar 1989
    Consegnato il 30 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,500,000 and all other moneys due or to become due from the M.I. group limited to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cornhill Insurance Public Limited Company.
    Transazioni
    • 30 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 02 dic 1988
    Consegnato il 21 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,000,000 and all other moneys due or to become due from the M.I. group limited to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Including stock in trade and work in progress. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cornhill Insurance Public Limited Company.
    Transazioni
    • 21 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 15 giu 1988
    Consegnato il 29 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,000,000 and all other moneys due or to become due from the M. I. Group limited to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Including stock in trade and work in progress. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Cornhill Insurance Public Limited Company.
    Transazioni
    • 29 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 27 apr 1988
    Consegnato il 17 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,870,000 & all other monies due or to become due from the M.I. group limited to the chargee under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    All fixed assets of the company both present and future and the undertaking & all other property assets and rights of the company whatsoever wheresoever both present & future including stock-in-trade and work in progress of the company.
    Persone aventi diritto
    • Cornhill Insurance Public Limited Company
    Transazioni
    • 17 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 25 ago 1987
    Consegnato il 15 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £14,750,000 and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to cornhill insurance company under the terms of this deed.
    Brevi particolari
    All fixed assets of the company both present and future and the undertaking and all other property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future including stock in trade and work in progress of the company.
    Persone aventi diritto
    • Cornhill Insurance Public Limited Company.
    Transazioni
    • 15 set 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 19 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    20TWENTY INDEPENDENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 ott 2013Inizio della liquidazione
    22 apr 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Lane Gary Bednash
    34 Ely Place
    EC1N 6TD London
    Praticante
    34 Ely Place
    EC1N 6TD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0