PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED

PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPHOENIX VENTURE LEASING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02130660
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Devon Lodge
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MCC LEASING (NO 18) LIMITED11 mag 198711 mag 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al14 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2015

    Stato del capitale al 13 gen 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Park Macclesfield Cheshire SK11 0LP a Devon Lodge Iddesleigh Winkleigh Devon EX19 8BE in data 13 gen 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 gen 2014

    Stato del capitale al 13 gen 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Jane Elizabeth Ruston il 31 dic 2012

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da * Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Park Macclesfield Cheshire SK11 0LP United Kingdom* in data 12 gen 2013

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Suite 14 Beechfield House Winterton, Way Lyme Green Business Park, Macclesfield Cheshire SK11 0LP* in data 12 gen 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2010

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Peter Anthony Martin Dillon come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Beale come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2009

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2008

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2007

    3 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 15 dic 2006

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RUSTON, Jane Elizabeth
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    Segretario
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    British70986180008
    DILLON, Peter Anthony Martin
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    Amministratore
    Iddesleigh
    EX19 8BE Winkleigh
    Devon Lodge
    Devon
    England
    United KingdomBritish129983290001
    RUFFELL, Lara Catherine
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    23 Meadowlands
    Chineham
    RG24 8XL Basingstoke
    Hampshire
    British69140140002
    RUSTON, Jane
    5 The Stables
    Berkswell Hall Berkswell
    CV7 7BG Coventry
    West Midlands
    Segretario
    5 The Stables
    Berkswell Hall Berkswell
    CV7 7BG Coventry
    West Midlands
    British70986180001
    SCOTT, Elizabeth Mary
    8 Belvidere Road
    WS1 3AU Walsall
    Segretario
    8 Belvidere Road
    WS1 3AU Walsall
    British76715280003
    SHOOLBRED, Charles Frederick
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    Segretario
    Timbers
    Dean Oak Lane
    RH2 8PZ Leigh
    Surrey
    British540290002
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Segretario
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    EVER 1993 LIMITED
    International Headquarters
    Longbridge
    B31 2TB Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    International Headquarters
    Longbridge
    B31 2TB Birmingham
    West Midlands
    88822950001
    BEALE, Peter Robert
    Dunhampstead House
    Dunhampstead
    WR9 7JX Droitwich Spa
    West Midlands
    Amministratore
    Dunhampstead House
    Dunhampstead
    WR9 7JX Droitwich Spa
    West Midlands
    United KingdomBritish25365060002
    BOX, Sarah
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Court Lodge Lower Road
    West Farleigh
    ME15 0PD Maidstone
    Kent
    British47381630004
    CALLENDER, John Dalrymple
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    Amministratore
    Fairway Heights
    GU15 1NJ Camberley
    14
    Surrey
    United KingdomBritish2444200001
    CLARK, Thomas Martin
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Hatch Hill Hatch Lane
    Kingsley Green
    GU27 3LJ Haslemere
    Surrey
    British5529800001
    DOWDING, Eric Robert
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    Amministratore
    23 Waldorf Heights
    Blackwater Howley Hill
    GU17 9JH Camberley
    Surrey
    British46728970001
    ELLIS, David James
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    Batts Row Cottage
    Laverstoke Lane, Laverstoke
    RG28 7PA Whitchurch
    Hampshire
    EnglandBritish113760650001
    LEWIS, Barry Randall
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    37 Main Road
    Littleton
    SO22 6QJ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish145163830001
    MACINTOSH, Gordon Paterson
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    7 Paddock Field
    Chilbolton
    SO20 6AU Stockbridge
    Hampshire
    British25737780001
    MILLINER, Craig
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    Amministratore
    21 Smithson Close
    Talbot Village
    BH12 5EY Poole
    Dorset
    British144700710001
    ROWAN, Charles Paul
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    32 Queens Park West Drive
    Queens Park
    BH8 9DD Bournemouth
    Dorset
    British49237910001
    ROWBERRY, Duncan John
    1 Feld Way
    Lychpit
    RG24 8UW Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    1 Feld Way
    Lychpit
    RG24 8UW Basingstoke
    Hampshire
    British49237880001
    RUSTON, Jane Elizabeth
    4 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    4 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish70986180008
    SILCOCK, Frank Avis
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Charleston 74 Wellhouse Road
    Beech
    GU34 4AG Alton
    Hampshire
    British32895910001
    WATSON, Hazel Anne Marie
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    Amministratore
    6 Abbotsmead Place
    Caversham
    RG4 8BB Reading
    Reading
    British71785600001
    WEAL, Barry
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Orchard Gate
    Mill Lane Bramley
    GU5 0HW Guildford
    Surrey
    British40203100001
    WEAVING, John Martin
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    57 Bridle Way
    Colehill
    BH21 2UP Wimborne
    Dorset
    British58523120001
    BARCOSEC LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    49004930001
    BAROMETERS LIMITED
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    57357300002

    PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment of insurances
    Creato il 24 mag 2002
    Consegnato il 10 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right,title and interest in and to insurances and any proceeds of requisition thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC,as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of insurances
    Creato il 24 mag 2002
    Consegnato il 10 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right,title and interest in and to the insurances and any proceeds of requisition. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC,as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Aircraft mortgage
    Creato il 24 mag 2002
    Consegnato il 10 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interest in and to the aircraft and all technical records and all engines thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC,as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Aircraft mortgage
    Creato il 24 mag 2002
    Consegnato il 10 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interest in and to the aircraft,the engines and all technical records. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC,as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment
    Creato il 24 mag 2002
    Consegnato il 10 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in respect of the assigned documents,as defined,and all moneys whatsoever payable thereunder including all claims for damages and compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC,as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment due under a group relief payment deed and certain repayments of corporation tax
    Creato il 24 mag 2002
    Consegnato il 30 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights,title,benefit and interest in and to the repayments of corporation tax paid by the company and all benefits/rights thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited and Thomson Travel International Ag
    Transazioni
    • 30 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0