PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02130660 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Devon Lodge Iddesleigh EX19 8BE Winkleigh Devon |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MCC LEASING (NO 18) LIMITED | 11 mag 1987 | 11 mag 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 14 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Park Macclesfield Cheshire SK11 0LP a Devon Lodge Iddesleigh Winkleigh Devon EX19 8BE in data 13 gen 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 gen 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 gen 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Jane Elizabeth Ruston il 31 dic 2012 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Beechfield House Winterton Way Lyme Green Business Park Macclesfield Cheshire SK11 0LP United Kingdom* in data 12 gen 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Suite 14 Beechfield House Winterton, Way Lyme Green Business Park, Macclesfield Cheshire SK11 0LP* in data 12 gen 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 gen 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Peter Anthony Martin Dillon come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Beale come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 gen 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2009 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 gen 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2008 | 3 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 14 dic 2007 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 15 dic 2006 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTON, Jane Elizabeth | Segretario | Iddesleigh EX19 8BE Winkleigh Devon Lodge Devon England | British | 70986180008 | ||||||
| DILLON, Peter Anthony Martin | Amministratore | Iddesleigh EX19 8BE Winkleigh Devon Lodge Devon England | United Kingdom | British | 129983290001 | |||||
| RUFFELL, Lara Catherine | Segretario | 23 Meadowlands Chineham RG24 8XL Basingstoke Hampshire | British | 69140140002 | ||||||
| RUSTON, Jane | Segretario | 5 The Stables Berkswell Hall Berkswell CV7 7BG Coventry West Midlands | British | 70986180001 | ||||||
| SCOTT, Elizabeth Mary | Segretario | 8 Belvidere Road WS1 3AU Walsall | British | 76715280003 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Segretario | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Segretario | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| EVER 1993 LIMITED | Segretario | International Headquarters Longbridge B31 2TB Birmingham West Midlands | 88822950001 | |||||||
| BEALE, Peter Robert | Amministratore | Dunhampstead House Dunhampstead WR9 7JX Droitwich Spa West Midlands | United Kingdom | British | 25365060002 | |||||
| BOX, Sarah | Amministratore | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Amministratore | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| CLARK, Thomas Martin | Amministratore | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| DOWDING, Eric Robert | Amministratore | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| ELLIS, David James | Amministratore | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| LEWIS, Barry Randall | Amministratore | 37 Main Road Littleton SO22 6QJ Winchester Hampshire | England | British | 145163830001 | |||||
| MACINTOSH, Gordon Paterson | Amministratore | 7 Paddock Field Chilbolton SO20 6AU Stockbridge Hampshire | British | 25737780001 | ||||||
| MILLINER, Craig | Amministratore | 21 Smithson Close Talbot Village BH12 5EY Poole Dorset | British | 144700710001 | ||||||
| ROWAN, Charles Paul | Amministratore | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| ROWBERRY, Duncan John | Amministratore | 1 Feld Way Lychpit RG24 8UW Basingstoke Hampshire | British | 49237880001 | ||||||
| RUSTON, Jane Elizabeth | Amministratore | 4 Mainwaring Road Over Peover WA16 8TR Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 70986180008 | |||||
| SILCOCK, Frank Avis | Amministratore | Charleston 74 Wellhouse Road Beech GU34 4AG Alton Hampshire | British | 32895910001 | ||||||
| WATSON, Hazel Anne Marie | Amministratore | 6 Abbotsmead Place Caversham RG4 8BB Reading Reading | British | 71785600001 | ||||||
| WEAL, Barry | Amministratore | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Amministratore | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Amministratore | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 49004930001 | |||||||
| BAROMETERS LIMITED | Amministratore | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | 57357300002 |
PHOENIX VENTURE LEASING LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of insurances | Creato il 24 mag 2002 Consegnato il 10 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right,title and interest in and to insurances and any proceeds of requisition thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment of insurances | Creato il 24 mag 2002 Consegnato il 10 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right,title and interest in and to the insurances and any proceeds of requisition. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Aircraft mortgage | Creato il 24 mag 2002 Consegnato il 10 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All interest in and to the aircraft and all technical records and all engines thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Aircraft mortgage | Creato il 24 mag 2002 Consegnato il 10 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All interest in and to the aircraft,the engines and all technical records. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security assignment | Creato il 24 mag 2002 Consegnato il 10 giu 2002 | In corso | Importo garantito All monies,liabilities and obligations due or to become due from the company,formerly known as mcc leasing (no 18) limited, (the "owner") to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights,title and interest in respect of the assigned documents,as defined,and all moneys whatsoever payable thereunder including all claims for damages and compensation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment due under a group relief payment deed and certain repayments of corporation tax | Creato il 24 mag 2002 Consegnato il 30 mag 2002 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights,title,benefit and interest in and to the repayments of corporation tax paid by the company and all benefits/rights thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0