GE CAPITAL TLS LTD
Panoramica
| Nome della società | GE CAPITAL TLS LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02131552 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GE CAPITAL TLS LTD?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova GE CAPITAL TLS LTD?
| Indirizzo della sede legale | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GE CAPITAL TLS LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TLS PLC | 13 giu 1995 | 13 giu 1995 |
| TLS RANGE PLC | 21 apr 1989 | 21 apr 1989 |
| TLS RANGE SELF DRIVE LIMITED | 09 set 1987 | 09 set 1987 |
| EASTHART LIMITED | 13 mag 1987 | 13 mag 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GE CAPITAL TLS LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per GE CAPITAL TLS LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 12 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 set 2021 | 9 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 set 2020 | 10 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 2 pagine | AD03 | ||||||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT | 2 pagine | AD02 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT a 1 More London Place London SE1 2AF in data 17 ott 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Lawrence John Gatt il 01 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Shahryar Mufti il 01 ago 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale al 31 mag 2019
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 mag 2019
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 32 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Scissione delle azioni al 28 mar 2019 | 4 pagine | SH02 | ||||||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Key Leasing Limited come persona con controllo significativo il 28 mar 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||||||
Cessazione di Ge Ese Uk Limited come persona con controllo significativo il 28 mar 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di GE CAPITAL TLS LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| GATT, Jonathan Lawrence John | Amministratore | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | Maltese | 228824220001 | |||||||||
| MUFTI, Shahryar | Amministratore | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 215531750001 | |||||||||
| MOYLE, Steven Taylor | Segretario | 8 Lyme Road Disley SK12 2LL Stockport Cheshire | British | 53092470002 | ||||||||||
| STEWART, John Wyllie | Segretario | Greystoke Fletsand Road SK9 2AB Wilmslow Cheshire | British | 995100002 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Segretario | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||||||
| TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED | Segretario | Trafalgar House 29 Park Place LS1 2SP Leeds West Yorkshire | 50087010001 | |||||||||||
| BEADLE, Paul Laurence | Amministratore | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 100238650001 | |||||||||
| BEEVER, David Milton Maxwell | Amministratore | Warren Farm House South Drive GU25 4JS Wentworth Surrey | United Kingdom | British | 35274610001 | |||||||||
| BRADLEY, Richard Todd | Amministratore | 500 Patriots Way Newtown Square 19073 Pennsylvania Usa | American | 54593440001 | ||||||||||
| BRINDLE, Philip Leigh | Amministratore | 21 Wrenpark Road Wingerworth S42 6RZ Chesterfield Derbyshire | British | 14271560001 | ||||||||||
| BUCCI, John Vincent | Amministratore | Summerhill Steels Lane, Oxshott KT22 0QQ Leatherhead Surrey | America | 81623160001 | ||||||||||
| BUSBY, Peter Stephen | Amministratore | 28 Hesketh Road PR9 9PD Southport Merseyside | United Kingdom | British | 73163760001 | |||||||||
| CONWAY, James Denis | Amministratore | 45 Lanton Road Newlands G43 2SR Glasgow | British | 36615600001 | ||||||||||
| D'AMMASSA, Carl Mark | Amministratore | The Smithy Bottoms Farm Warmingham Road CW1 4PJ Warmingham | British | 119207850001 | ||||||||||
| DE'ATH, Mark Robert | Amministratore | 4 Caxton Mews The Butts TW8 8BN Brentford Middlesex | British | 49303130003 | ||||||||||
| DELAMORE, Karen Ann | Amministratore | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 136619480001 | |||||||||
| DENVIR, Brian Anthony | Amministratore | 2/4 Dunscar Cottages Dunscar,Egerton BL7 9EP Bolton Lancashire | British | 32346480001 | ||||||||||
| EVANS, Marshall Owen | Amministratore | Warwick House 47 Stewkley Road Wing LU7 0NJ Leighton Buzzard Bedfordshire | United Kingdom | British | 42930970001 | |||||||||
| FAST, Robert Alain | Amministratore | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire United Kingdom | Netherlands | American | 89843360002 | |||||||||
| GRIFFIN, Kevin Thomas | Amministratore | 201 Talgarth Road Hammersmith W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | Irish | 122136120001 | |||||||||
| HODGKISS, Roger Hilton | Amministratore | The Old Stables Ingthorne Lane South Milford LS25 5DH Leeds | United Kingdom | British | 76993260001 | |||||||||
| JULIANO, Alan Joseph | Amministratore | Museumplein 7-11 FOREIGN Amsterdam 1071 Dj Netherland | American | 125150100001 | ||||||||||
| MANNION, Eileen Frances | Amministratore | 74 Church Street SK13 7RN Old Glossop Derbyshire | British | 119358410001 | ||||||||||
| MCENROE, Malachy | Amministratore | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire United Kingdom | Irish | 139465450001 | ||||||||||
| MILLAY, Roger Foster | Amministratore | 1323 Shadow Oak Drive PA 19355 Malvern Usa | American | 56302140001 | ||||||||||
| MILLER, Clive John | Amministratore | Glenfield 234 Mottram Road SK15 2RY Stalybridge Cheshire | England | British | 585590001 | |||||||||
| MINETT, Timothy William | Amministratore | Ivy End, Wattlesborough SY5 9EA Shrewsbury Shropshire | British | 141648470001 | ||||||||||
| OLIVER, John Lancaster | Amministratore | Muhlgasse 11 Berg Bayern 82335 Germany | British | 87846400001 | ||||||||||
| PAREKH, Girish | Amministratore | Fairhaven 1 Kings Drive Fulwood PR2 3HN Preston | British | 84067630001 | ||||||||||
| ROBERTS, Peter Arnold | Amministratore | Beechwood Cottage 64 Crouchley Lane WA13 0AT Lymm Cheshire | British | 9290450001 | ||||||||||
| SMITH, Neil Campbell | Amministratore | 201 Talgarth Road Hammersmith W6 8BJ London The Ark United Kingdom | United Kingdom | British | 183029170001 | |||||||||
| STEED, Gareth Andrew Richard | Amministratore | 27 Brooklawn Drive M20 3GY Manchester Lancashire | United Kingdom | British | 242558020001 | |||||||||
| STEWART, John Wyllie | Amministratore | Greystoke Fletsand Road SK9 2AB Wilmslow Cheshire | British | 995100002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GE CAPITAL TLS LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ge Ese Uk Limited | 06 apr 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Key Leasing Limited | 06 apr 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per GE CAPITAL TLS LTD?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 02 mag 2017 | 01 dic 2017 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
GE CAPITAL TLS LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment by way of security and charge of sub-leases | Creato il 21 lug 1995 Consegnato il 03 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the acquisition documents and the security documents on any account whatsoever | |
Brevi particolari All right title & interest in & to the charged property and all moneys payable the net proceeds of any claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 26 apr 1995 Consegnato il 01 mag 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage land and buildings lying to the south west of king william street, salford t/no. GM672020 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 14 nov 1994 Consegnato il 17 nov 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the company's interest in all motor vehicles ("the vehicles") together with the benefit of all contracts securities guarantees and indemnities and all proceeds of sale, insurance claims and debts etc. due to the company in relation to any of the vehicles or contracts. Floating charge all the company's interest in the motor vehicles and equipment mentioned above and the proceeds of sale insurance claims and debts etc. in relation thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A first fixed charge | Creato il 22 giu 1994 Consegnato il 25 giu 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreements or lease agreements entered into | |
Brevi particolari First fixed charge all sub-lease agreements entered into at any time by the company with customers of the company relating to goods owned by the company but let by mbf to the company under hire purchase agreements or lease agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 11 mag 1994 Consegnato il 19 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1) land and buildings on the south west side of victory road blackpool t/n la 411266. 2) land and buildings on the north east side of gorton blackpool t/n la 696245. 3) land and buildings k/a 102 gorton street blackpool. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of charge | Creato il 28 feb 1994 Consegnato il 02 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All present and future contracts of lease or hire made by the company in relation to all or any goods which are in the process of becoming acquired by the company from the owner. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 30 nov 1987 Consegnato il 11 dic 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the west side of chalfont street, salford greater manchester (see form 395 for full property details) and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 nov 1987 Consegnato il 07 dic 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
GE CAPITAL TLS LTD ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0