FESTIVAL CITY LIMITED

FESTIVAL CITY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFESTIVAL CITY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02136268
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FESTIVAL CITY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FESTIVAL CITY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor The Outset
    Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FESTIVAL CITY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    POLITEWONDER LIMITED01 giu 198701 giu 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di FESTIVAL CITY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per FESTIVAL CITY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 gen 2021

    10 pagineLIQ03

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da 17 King Street Knutsford Cheshire WA16 6DW England a 1st Floor the Outset Sankey Street Warrington WA1 1NN in data 04 feb 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 gen 2020

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 ott 2018

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 130 Buxton Road Stockport Cheshire SK2 6PL a 17 King Street Knutsford Cheshire WA16 6DW in data 17 nov 2019

    1 pagineAD01

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Notifica di Linda Joan Phillips come persona con controllo significativo il 17 nov 2018

    2 paginePSC01

    Nomina di Mrs Linda Joan Phillips come amministratore in data 03 apr 2019

    2 pagineAP01

    Modifica dei dettagli di una persona con controllo significativo

    2 paginePSC04

    Cessazione della carica di Charles David Phillips come amministratore in data 16 nov 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles David Phillips come segretario in data 16 nov 2018

    1 pagineTM02

    Cessazione di Charles David Phillips come persona con controllo significativo il 16 nov 2018

    1 paginePSC07

    Nomina di Mrs Linda Joan Phillips come segretario in data 02 apr 2019

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 ott 2017

    2 pagineAA

    Cessazione della carica di Linda Joan Phillips come amministratore in data 30 apr 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di FESTIVAL CITY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PHILLIPS, Linda Joan
    11, Poplar Avenue
    L23 7ST Crosby
    11,Poplar Avenue
    Merseyside
    United Kingdom
    Segretario
    11, Poplar Avenue
    L23 7ST Crosby
    11,Poplar Avenue
    Merseyside
    United Kingdom
    257287560001
    PHILLIPS, Linda Joan
    11, Poplar Avenue
    L23 7ST Crosby
    11, Poplar Avenue
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    11, Poplar Avenue
    L23 7ST Crosby
    11, Poplar Avenue
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish257364400001
    PHILLIPS, Charles David
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    England
    Segretario
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    England
    178390180001
    PHILLIPS, Charles David
    Yew Tree House
    Free Green Lane
    WA16 9PS Lower Peover
    Cheshire
    Segretario
    Yew Tree House
    Free Green Lane
    WA16 9PS Lower Peover
    Cheshire
    British34424750002
    PHILLIPS, Josephine Mary
    Yew Tree House
    Free Green Lane, Lower Peover
    WA16 9PS Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    Yew Tree House
    Free Green Lane, Lower Peover
    WA16 9PS Knutsford
    Cheshire
    British67372980003
    PHILLIPS, Linda Joan
    11 Poplar Avenue
    Crosby
    L23 2ST Liverpool
    Segretario
    11 Poplar Avenue
    Crosby
    L23 2ST Liverpool
    British17672250001
    R S NOMINEES LIMITED
    Didsbury House
    748 Wilmslow Road Didsbury
    M20 2DW Manchester
    1st Floor
    Segretario
    Didsbury House
    748 Wilmslow Road Didsbury
    M20 2DW Manchester
    1st Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3114059
    52646340002
    BIRCH, George Henry Edward
    12 West Orchard Lane
    Fazakerley
    L9 9EF Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    12 West Orchard Lane
    Fazakerley
    L9 9EF Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish30216650003
    PHILLIPS, Charles David
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    England
    EnglandBritish207826790001
    PHILLIPS, Charles David
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34424750003
    PHILLIPS, Linda Joan
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish17672250002

    Chi sono le persone con controllo significativo di FESTIVAL CITY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Linda Joan Phillips
    Poplar Avenue
    L23 2ST Liverpool
    11,Poplar Avenue
    England
    17 nov 2018
    Poplar Avenue
    L23 2ST Liverpool
    11,Poplar Avenue
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Charles David Phillips
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    01 giu 2016
    Buxton Road
    SK2 6PL Stockport
    130
    Cheshire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    FESTIVAL CITY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 mag 2016
    Consegnato il 24 mag 2016
    In corso
    Breve descrizione
    37 and 39 queens road, formby, merseyside L37 2HG.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Suzanne Brown
    • Property Finance Consultants Limited
    Transazioni
    • 24 mag 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 ago 2013
    Consegnato il 21 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 ago 2013
    Consegnato il 21 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H property k/a 37-39 queens road formby t/nos MS57418 and MS252250. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 21 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 23 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 13 ago 2007
    Consegnato il 22 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    37-39 queens road formby merseyside t/n MS252250 and MS57418. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 lug 2007
    Consegnato il 06 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge
    Creato il 28 set 2001
    Consegnato il 04 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £191,250.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the provisions of the charge deed
    Brevi particolari
    The freehold property known as 132, 134 and 134A turves road, cheadle, hulme, cheshire, and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third party charge of securities (UK)
    Creato il 06 lug 2001
    Consegnato il 20 lug 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from tatton property investments (liverpool) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or securities (certificated or uncertificated) which are from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company to the bank together with all income derived from and rights attaching to the same.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 26 apr 2000
    Consegnato il 05 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 05 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of rental income
    Creato il 26 apr 2000
    Consegnato il 05 mag 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The right to receive all payments reserved as rent under the lease dated 30 april 1993. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 05 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Commercial mortgage
    Creato il 26 apr 2000
    Consegnato il 05 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a 22 high street stone staffordshire t/no SF413383 and all buildings fixtures plant and machinery..by way of first fixed charge all the goodwill of the business the full benefit of all licences consents permissions and agreements.. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • West Bromwich Building Society
    Transazioni
    • 05 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 mar 1999
    Consegnato il 13 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £145,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    22 high st,stone,staffordshire; sf 259197.
    Persone aventi diritto
    • Linda Joan Phillips
    Transazioni
    • 13 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mag 1998
    Consegnato il 13 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £80,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    27 chapel lane formby merseyside.
    Persone aventi diritto
    • Linda Joan Phillips
    Transazioni
    • 13 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mag 1998
    Consegnato il 09 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West PLC
    Transazioni
    • 09 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rental assignment
    Creato il 29 mag 1998
    Consegnato il 02 giu 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest of the company in and to all rent, licence fees or other sums received by the company from any tenant or licensee of the property k/a 27 chapel lane formby t/nos.MS384772 and MS363921. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Commercial mortgage
    Creato il 29 mag 1998
    Consegnato il 02 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    27 chapel lane formby t/nos.MS384772 and MS363921 together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery. The benefit of all guarantees indemnities rent deposits. By way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights. Assigns the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rental assignment
    Creato il 02 mar 1998
    Consegnato il 04 mar 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rent, licence fees or other sums of money now or at any time received or recoverable by the company from any any tenant or licensee of the property k/a 48 king street knutsford or any part thereof.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Commercial mortgage
    Creato il 02 mar 1998
    Consegnato il 04 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 48 king street knutford together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery. The benefit of all guarantees indemnities rent deposits. By way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights. Assigns the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance.
    Persone aventi diritto
    • Bristol & West PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage and general charge
    Creato il 25 gen 1995
    Consegnato il 07 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £435,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H property k/a 27 chapel lane, formby, merseyside. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Linda Joan Phillips
    Transazioni
    • 07 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FESTIVAL CITY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 gen 2020Inizio della liquidazione
    28 nov 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Peter Fisher
    Parkin S Booth & Co 1st Floor The Outset
    (Bank Quay House) Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Cheshire
    Praticante
    Parkin S Booth & Co 1st Floor The Outset
    (Bank Quay House) Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Cheshire
    Ian Cathrell Brown
    1st Floor The Outset (Bank Quay House) Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Cheshire
    Praticante
    1st Floor The Outset (Bank Quay House) Sankey Street
    WA1 1NN Warrington
    Cheshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0