THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED

THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE CROMER CRAB COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02140583
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED?

    • Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi (10200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 lug 2021

    6 pagineLIQ03

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Nomina di un liquidatore volontario

    42 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH a 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE in data 07 mag 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW a 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH in data 05 ago 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 lug 2020

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Cessazione di The Seafood Company Limited come persona con controllo significativo il 29 mar 2020

    1 paginePSC07

    Notifica di Young's Seafood Ltd come persona con controllo significativo il 29 mar 2020

    2 paginePSC02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 mar 2020

    • Capitale: GBP 2
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduce share prem a/c 18/03/2020
    RES13

    Cessazione della carica di Jenny Nancy Loncaster come amministratore in data 25 set 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Mark Busby come amministratore in data 12 set 2019

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 mar 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Wilkin Chapman Llp New Oxford House Town Hall Square Grimsby South Humberside DN31 1HE United Kingdom a Karro Food Group Hugden Way, Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Wilkin Chapman Llp New Oxford House Town Hall Square Grimsby South Humberside DN31 1HE

    1 pagineAD03

    Nomina di Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont come amministratore in data 04 lug 2019

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited come segretario in data 04 lug 2019

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Amministratore
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBelgian231792890001
    MARSHALL, Paul Scott
    Tall Trees 17 Pond Lane
    Drayton
    NR8 6PP Norwich
    Norfolk
    Segretario
    Tall Trees 17 Pond Lane
    Drayton
    NR8 6PP Norwich
    Norfolk
    British59735070001
    MARSHALL, Paul Scott
    Tall Trees 17 Pond Lane
    Drayton
    NR8 6PP Norwich
    Norfolk
    Segretario
    Tall Trees 17 Pond Lane
    Drayton
    NR8 6PP Norwich
    Norfolk
    British59735070001
    WILLIAMS, John Francis
    The Springles
    NR27 9PS East Runton
    Springall House
    Norfolk
    United Kingdom
    Segretario
    The Springles
    NR27 9PS East Runton
    Springall House
    Norfolk
    United Kingdom
    British137156740001
    WCPHD SECRETARIES LIMITED
    5th Floor Alder Castle
    10 Noble Street
    EC2V 7QJ London
    Segretario
    5th Floor Alder Castle
    10 Noble Street
    EC2V 7QJ London
    88132420006
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Segretario nominato
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02249348
    900013350001
    ANTHONY, Rex
    179 Waterford Bridge Road
    St John's
    Newfoundland A1e 1c7
    Canada
    Amministratore
    179 Waterford Bridge Road
    St John's
    Newfoundland A1e 1c7
    Canada
    Canadian123573570001
    BRIGHT, Mark Andrew
    Fairways Cromer Road
    Thorpe Market
    NR11 8TW Norwich
    Amministratore
    Fairways Cromer Road
    Thorpe Market
    NR11 8TW Norwich
    British62002800001
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    BUSBY, Timothy Mark
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandEnglish169852920001
    BYRNE, Paul Christopher
    The Firs
    Tonbridge Road
    TN11 0AT Hadlow
    Kent
    Amministratore
    The Firs
    Tonbridge Road
    TN11 0AT Hadlow
    Kent
    British119919960001
    DANCASTER, Frank Gilbert
    Beeston Croft
    Cromer Road Beeston Regis
    NR27 9NG Cromer
    Norfolk
    Amministratore
    Beeston Croft
    Cromer Road Beeston Regis
    NR27 9NG Cromer
    Norfolk
    British43099550001
    ENNIS, Terence Edward
    Devonshire House
    High Street
    RH17 6BJ Handcross
    West Sussex
    Amministratore
    Devonshire House
    High Street
    RH17 6BJ Handcross
    West Sussex
    Canadian110044980001
    FORBES, Hamish Drummond
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish66295550001
    GREY, Michael Stuart
    Millstream House
    Beach Lane, Weybourne
    NR25 7SR Holt
    Norfolk
    Amministratore
    Millstream House
    Beach Lane, Weybourne
    NR25 7SR Holt
    Norfolk
    British83686610001
    GRIFFITHS, Wayne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    N E Lincolnshire
    Amministratore
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    N E Lincolnshire
    British108643650001
    HARKJAER, Per
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Oakridge House
    6 Montrose Gardens Oxshott
    KT22 0UU Leatherhead
    Surrey
    EnglandDanish127032620001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    Ross House
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish205633180001
    MARSHALL, Paul Scott
    Tall Trees 17 Pond Lane
    Drayton
    NR8 6PP Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Tall Trees 17 Pond Lane
    Drayton
    NR8 6PP Norwich
    Norfolk
    British59735070001
    MARTIN, Richard William Thomas
    9 Somes Close
    Uffington
    PE9 4UE Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    9 Somes Close
    Uffington
    PE9 4UE Stamford
    Lincolnshire
    British37115510004
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Amministratore
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    PARKIN, Reginald Colin
    Home House
    High Street
    NR27 9HG Cromer
    Norfolk
    Amministratore
    Home House
    High Street
    NR27 9HG Cromer
    Norfolk
    EnglandBritish93252530001
    RISLEY, John
    25 Pig Loop Road
    Chester
    Nova Scotia Boj 1jo
    Canada
    Amministratore
    25 Pig Loop Road
    Chester
    Nova Scotia Boj 1jo
    Canada
    Canadian125119300001
    WILLIAMS, John Francis
    The Springles
    NR27 9PS East Runton
    Springall House
    Norfolk
    United Kingdom
    Amministratore
    The Springles
    NR27 9PS East Runton
    Springall House
    Norfolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish137156740001
    YOUNG, Norman William
    Mockbridge Malthouse
    Horsham Road
    BN5 9AD Henfield
    West Sussex
    Amministratore
    Mockbridge Malthouse
    Horsham Road
    BN5 9AD Henfield
    West Sussex
    British13371710001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    29 mar 2020
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    No
    Forma giuridicaYoung'S Seafood Ltd
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3751665
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    The Seafood Company Limited
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06 apr 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House, England & Wales
    Numero di registrazione03136293
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 ott 2008
    Consegnato il 01 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 01 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 set 2008
    Consegnato il 04 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 04 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 25 ott 2007
    Consegnato il 07 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale as Securuty Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 07 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 lug 2006
    Consegnato il 27 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Glitnir Banki Hf.
    Transazioni
    • 27 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 set 1998
    Consegnato il 24 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at holt road cromer norfolk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 gen 1996
    Consegnato il 16 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land at norwich road, cromer, norfolk as comprised in a lease dated 25TH november 1994.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 gen 1996
    Consegnato il 16 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a premises at norwich road, cromer, norfolk as comprised in a lease dated 5TH july 1994.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1995
    Consegnato il 19 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a the easement of a pipeline at norwich road, cromer, norfolk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1995
    Consegnato il 19 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a premises at norwich road, cromer, norfolk.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 18 dic 1995
    Consegnato il 19 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    THE CROMER CRAB COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 lug 2020Inizio della liquidazione
    13 gen 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas James Timpson
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Mark Jeremy Orton
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Praticante
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0