VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED

VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02144162
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED?

    • (7222) /

    Dove si trova VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Furnival Street
    EC4A 1YH London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARRIERZEUROS LIMITED04 apr 200104 apr 2001
    HARRIER ZEUROS LIMITED11 lug 200011 lug 2000
    HARRIER NETWORK SOLUTIONS LIMITED02 ott 199602 ott 1996
    HARRIER COMPUTER SYSTEMS LIMITED02 lug 198702 lug 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 mar 2011

    50 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 01 apr 2011

    51 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 02 mar 2011

    51 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da 66 Wigmore Street London W1U 2SB in data 03 mar 2011

    2 pagineAD01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    179 pagine2.17B

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 set 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Indirizzo della sede legale modificato da Innovation House Millbrook Business Park Mill Lane Rainford WA11 8LZ in data 16 set 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di David Hargaden come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Essex Trust Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Daniel Holohan come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 mar 2010

    Stato del capitale al 17 mar 2010

    • Capitale: GBP 1,312,420
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Guarantee 21/08/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Guarantee 16/09/2008
    RES13

    legacy

    6 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ESSEX TRUST LIMITED
    Floor
    Beaux Lane House Mercer Street Lower
    Dublin 2
    5th
    Ireland
    Segretario
    Floor
    Beaux Lane House Mercer Street Lower
    Dublin 2
    5th
    Ireland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione251687
    151027690001
    BRADY, Tara Christopher
    14 Ellesmere Close
    E11 1PT London
    Amministratore
    14 Ellesmere Close
    E11 1PT London
    United KingdomBritish145701300001
    HEALY, Maurice Leonard
    Knocksinna
    Foxrock
    Dublin 18
    "Glencroe"
    Ireland
    Amministratore
    Knocksinna
    Foxrock
    Dublin 18
    "Glencroe"
    Ireland
    IrelandIrish59920210002
    BICKLEY, Richard Matthew
    2 Woodland View
    Threshfield
    BD23 5EX Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Woodland View
    Threshfield
    BD23 5EX Skipton
    North Yorkshire
    British77150410001
    COURT, Simon Mark
    25 Wispington Close
    Lower Earley
    RG6 3BN Reading
    Segretario
    25 Wispington Close
    Lower Earley
    RG6 3BN Reading
    British63114280001
    HOLOHAN, Daniel Joseph
    17 Ardlea,
    Trim Road
    IRISH Dunshaughlin
    Co. Meath
    Ireland
    Segretario
    17 Ardlea,
    Trim Road
    IRISH Dunshaughlin
    Co. Meath
    Ireland
    Irish114162330001
    LEE, Christopher James
    Garden Cottage
    Ledgers Lane
    CR6 9QB Chelsham
    Surrey
    Segretario
    Garden Cottage
    Ledgers Lane
    CR6 9QB Chelsham
    Surrey
    British120977620001
    MEREDITH, Trevor William
    16 Conisboro Avenue
    Caversham
    RG4 7JB Reading
    Berkshire
    Segretario
    16 Conisboro Avenue
    Caversham
    RG4 7JB Reading
    Berkshire
    British30322110001
    ROWLINSON, Mark Andrew
    2 Wellswood
    SL5 7EA Ascot
    Berkshire
    Segretario
    2 Wellswood
    SL5 7EA Ascot
    Berkshire
    British104599810001
    STARNES, Martyn John
    11 Corfield Close
    RG11 4PA Finchampstead
    Berkshire
    Segretario
    11 Corfield Close
    RG11 4PA Finchampstead
    Berkshire
    British34872420001
    WEATHERITT, Bob
    7 Brookhurst Court
    Beverley Road
    CV32 6PB Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    7 Brookhurst Court
    Beverley Road
    CV32 6PB Leamington Spa
    Warwickshire
    British66497140001
    BEACH SECRETARIES LIMITED
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    Segretario
    100 Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    76729800001
    BICKLEY, Richard Matthew
    2 Woodland View
    Threshfield
    BD23 5EX Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Woodland View
    Threshfield
    BD23 5EX Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish77150410001
    BRADLEY, Colin
    4 Chestnut Grove
    Moreton Morrell
    CV35 9DG Warwick
    Amministratore
    4 Chestnut Grove
    Moreton Morrell
    CV35 9DG Warwick
    British35879250002
    BUGDEN, Wayne Bamber David
    16 Medina Close
    Woosehill
    RG11 9TZ Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    16 Medina Close
    Woosehill
    RG11 9TZ Wokingham
    Berkshire
    British32678300001
    CARTER, Sarah Louise
    The Cottage
    24 Russell Street, Stony Stratford
    MK11 1BT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Cottage
    24 Russell Street, Stony Stratford
    MK11 1BT Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British67062630001
    CHEESMAN, David
    Tudor Barn
    Frog Lane, Rotherwick
    RG27 9BE Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Tudor Barn
    Frog Lane, Rotherwick
    RG27 9BE Hook
    Hampshire
    British69718990002
    COAKLEY, Gerard
    161 Stillorgan Heath
    IRISH Stillorgan
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    161 Stillorgan Heath
    IRISH Stillorgan
    Co Dublin
    Ireland
    Irish112426940001
    COURT, Simon Mark
    25 Wispington Close
    Lower Earley
    RG6 3BN Reading
    Amministratore
    25 Wispington Close
    Lower Earley
    RG6 3BN Reading
    British63114280001
    DAVIES, Richard
    Redwood
    Swallowfield Road Arborfield
    RG2 9JY Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Redwood
    Swallowfield Road Arborfield
    RG2 9JY Reading
    Berkshire
    British80939270001
    HARGADEN, David
    2 St James Terrace
    Clonskeagh Road
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    2 St James Terrace
    Clonskeagh Road
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish140574350001
    HEALY, Maurice Leonard
    Glencroe
    Knocksinna
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    Glencroe
    Knocksinna
    IRISH Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish59920210002
    MEREDITH, Trevor William
    16 Conisboro Avenue
    Caversham
    RG4 7JB Reading
    Berkshire
    Amministratore
    16 Conisboro Avenue
    Caversham
    RG4 7JB Reading
    Berkshire
    British30322110001
    NICHOLL, Julia
    Tudor Barn
    Frog Lane, Rotherwick
    RG27 9BE Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Tudor Barn
    Frog Lane, Rotherwick
    RG27 9BE Hook
    Hampshire
    British74075870003
    RADFORD, Terry Clive
    Monks Ford
    Monks Sherborne
    RG26 5HX Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Monks Ford
    Monks Sherborne
    RG26 5HX Basingstoke
    Hampshire
    British13904850003
    RICKETTS, Simon Peter Edward
    331 West Wycombe Road
    HP12 4AD High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    331 West Wycombe Road
    HP12 4AD High Wycombe
    Buckinghamshire
    British39976000001
    ROWLINSON, Mark Andrew
    2 Wellswood
    SL5 7EA Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    2 Wellswood
    SL5 7EA Ascot
    Berkshire
    British104599810001
    SMITH, Andrew Ian
    The Lodge
    31 Hook Hill
    CR2 0LB Sanderstead
    Surrey
    Amministratore
    The Lodge
    31 Hook Hill
    CR2 0LB Sanderstead
    Surrey
    EnglandEnglish94602120001
    STARNES, Martyn John
    11 Corfield Close
    RG11 4PA Finchampstead
    Berkshire
    Amministratore
    11 Corfield Close
    RG11 4PA Finchampstead
    Berkshire
    British34872420001
    WEAVER, Anthony
    Freshfields
    Maynards Green
    TN21 0DE Heathfield
    East Sussex
    Amministratore
    Freshfields
    Maynards Green
    TN21 0DE Heathfield
    East Sussex
    United KingdomBritish1435050002
    WEBSTER, Coun
    27 Lymington Close
    RG22 4XL Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    27 Lymington Close
    RG22 4XL Basingstoke
    Hampshire
    British74076010001
    WILLIAMS, Nicholas
    Heath Ride
    Finchampstead
    RG40 3QJ Wokingham
    Sandy Way
    Berkshire
    Amministratore
    Heath Ride
    Finchampstead
    RG40 3QJ Wokingham
    Sandy Way
    Berkshire
    EnglandBritish160931630001

    VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 17 set 2008
    Consegnato il 29 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 29 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite debenture
    Creato il 29 ago 2008
    Consegnato il 11 set 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 11 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 nov 2007
    Consegnato il 28 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Security Trustee for the Secured Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 30 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 ott 1999
    Consegnato il 22 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 mag 1996
    Consegnato il 18 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 26 mag 1993
    Consegnato il 28 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Kellock Limited
    Transazioni
    • 28 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 giu 1990
    Consegnato il 20 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See form 395 relevant to this charge). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 20 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 gen 1989
    Consegnato il 18 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts present and future.
    Persone aventi diritto
    • Udt Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 18 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 04 mar 1988
    Consegnato il 10 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1988Registrazione di un'ipoteca

    VIKINGS REALISATIONS 4 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 set 2010Inizio dell'amministrazione
    01 apr 2011Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip Lewis Armstrong
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Praticante
    66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Geoffrey Paul Rowley
    Po Box 2653 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London
    Praticante
    Po Box 2653 66 Wigmore Street
    W1A 3RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0