J L DESIGN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | J L DESIGN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02145231 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di J L DESIGN LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova J L DESIGN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 10 Triton Street Regent's Place NW1 3BF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di J L DESIGN LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TWO-CAN PUBLISHING LIMITED | 30 nov 1987 | 30 nov 1987 |
| HANDWORK LIMITED | 07 lug 1987 | 07 lug 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di J L DESIGN LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per J L DESIGN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Nomina di Ms Mary Margaret Basterfield come amministratore in data 24 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Margaret Price come amministratore in data 23 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew John Moberly come segretario in data 24 nov 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Tracy De Groose come amministratore in data 27 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Claire Margaret Price come amministratore in data 27 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kashmir Singh Sohi come amministratore in data 27 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Kay come amministratore in data 27 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sara Lynn Jarvis come amministratore in data 27 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2016 al 31 dic 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 136-142 Bramley Road London W10 6SR a 10 Triton Street Regent's Place London NW1 3BF in data 20 mag 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Kashmir Singh Sohi come amministratore in data 05 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Alex Silcox come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alex Silcox come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey Stevens come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di J L DESIGN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBERLY, Andrew John | Segretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | 205300310001 | |||||||
| BASTERFIELD, Mary Margaret | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 | United Kingdom | British | 295094520001 | |||||
| DE GROOSE, Tracy Anne | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | England | British | 171412510001 | |||||
| HIRSCH, Andrew Mark | Amministratore | 64 Parliament Hill NW3 2TL London | England | British | 107066560001 | |||||
| BOALER, Kate Louise | Segretario | 19 Johnson Road BR2 9SN Bromley Kent | British | 73267320001 | ||||||
| CAMPKIN, Christopher John | Segretario | 86 Elthorne Park Road W7 2JD London | British | 78308230002 | ||||||
| CANN, Stephen Derek | Segretario | 51 Newtons Close RM13 7AX Rainham Essex | British | 18501650001 | ||||||
| FITZPATRICK, Dean Marvin | Segretario | 26 Cranbourne Road N10 2BT London | British | 81553650001 | ||||||
| GRANT, Ian Gordon | Segretario | 52 Gladsmuir Road Upper Holloway N19 3JU London | British | 22290880001 | ||||||
| SILCOX, Alex David | Segretario | 136-142 Bramley Road London W10 6SR | 175851410001 | |||||||
| AMEN, Patrice | Amministratore | Les Amazones FOREIGN 31320 Anzeville France | French | 22290870001 | ||||||
| BAKER, Roger Christopher | Amministratore | 10 Devereux Drive WD17 3DE Watford | British | 81553490001 | ||||||
| BROWN, John Dominic Weare | Amministratore | 120 Elgin Crescent W11 2JL London | United Kingdom | British | 35549390002 | |||||
| CAMPKIN, Christopher John | Amministratore | 86 Elthorne Park Road W7 2JD London | Great Britain | British | 78308230002 | |||||
| FITZPATRICK, Dean Marvin | Amministratore | 26 Cranbourne Road N10 2BT London | England | British | 81553650001 | |||||
| GRANT, Ian Gordon | Amministratore | 52 Gladsmuir Road Upper Holloway N19 3JU London | England | British | 22290880001 | |||||
| JARVIS, Andrew Calmson | Amministratore | 8 West Hill Court Millfield Lane N6 6JJ London | United Kingdom | British | 10930910002 | |||||
| JARVIS, Sara Lynn | Amministratore | 77 Roupell Street SE1 8SS London | United Kingdom | British | 18501680001 | |||||
| KAY, Elizabeth | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | England | British | 176507210001 | |||||
| MAZERIES, Michael | Amministratore | 20 Rue Saint Ursule FOREIGN 3100 Toulouse France | French | 22290850001 | ||||||
| ORIOL, Alain | Amministratore | 5 Chemin Des Sources FOREIGN 31120 Portet Sur Garonne France | French | 31584540001 | ||||||
| PRICE, Claire Margaret | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 England | England | British | 181956820001 | |||||
| PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor | Amministratore | Amersham Road HP13 6QS High Wycombe 21 Buckinghamshire | England | British | 17972160001 | |||||
| SILCOX, Alexander David | Amministratore | 136-142 Bramley Road London W10 6SR | England | British | 186834220001 | |||||
| SOHI, Kashmir Singh | Amministratore | Bramley Road W10 6SR London 136-142 England | England | British | 45116130003 | |||||
| STEVENS, Geoffrey Robert | Amministratore | Beech House 3 Millhouses Court S11 9HZ Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 57380020001 |
J L DESIGN LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Collateral debenture | Creato il 12 gen 1994 Consegnato il 14 gen 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 07 dic 1993 Consegnato il 14 dic 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A credit agreement | Creato il 08 dic 1992 Consegnato il 11 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £20800.34 due from the company to the chargee under the terms of an agreement | |
Brevi particolari All the right title and interest payable under the insurances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 ago 1989 Consegnato il 07 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 10 mar 1989 Consegnato il 17 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0