J L DESIGN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJ L DESIGN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02145231
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di J L DESIGN LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova J L DESIGN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di J L DESIGN LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TWO-CAN PUBLISHING LIMITED30 nov 198730 nov 1987
    HANDWORK LIMITED07 lug 198707 lug 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di J L DESIGN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per J L DESIGN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Ms Mary Margaret Basterfield come amministratore in data 24 ott 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Claire Margaret Price come amministratore in data 23 set 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew John Moberly come segretario in data 24 nov 2015

    2 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 nov 2015

    Stato del capitale al 03 nov 2015

    • Capitale: GBP 535,107
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    8 pagineAA

    Nomina di Ms Tracy De Groose come amministratore in data 27 lug 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Claire Margaret Price come amministratore in data 27 lug 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kashmir Singh Sohi come amministratore in data 27 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elizabeth Kay come amministratore in data 27 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sara Lynn Jarvis come amministratore in data 27 lug 2015

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2016 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da 136-142 Bramley Road London W10 6SR a 10 Triton Street Regent's Place London NW1 3BF in data 20 mag 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 set 2014

    Stato del capitale al 25 set 2014

    • Capitale: GBP 535,107
    SH01

    Nomina di Mr Kashmir Singh Sohi come amministratore in data 05 set 2014

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Alex Silcox come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alex Silcox come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Geoffrey Stevens come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 set 2013

    Stato del capitale al 27 set 2013

    • Capitale: GBP 535,107
    SH01

    Chi sono gli amministratori di J L DESIGN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOBERLY, Andrew John
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    Segretario
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    205300310001
    BASTERFIELD, Mary Margaret
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    Amministratore
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United KingdomBritish295094520001
    DE GROOSE, Tracy Anne
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    Amministratore
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    EnglandBritish171412510001
    HIRSCH, Andrew Mark
    64 Parliament Hill
    NW3 2TL London
    Amministratore
    64 Parliament Hill
    NW3 2TL London
    EnglandBritish107066560001
    BOALER, Kate Louise
    19 Johnson Road
    BR2 9SN Bromley
    Kent
    Segretario
    19 Johnson Road
    BR2 9SN Bromley
    Kent
    British73267320001
    CAMPKIN, Christopher John
    86 Elthorne Park Road
    W7 2JD London
    Segretario
    86 Elthorne Park Road
    W7 2JD London
    British78308230002
    CANN, Stephen Derek
    51 Newtons Close
    RM13 7AX Rainham
    Essex
    Segretario
    51 Newtons Close
    RM13 7AX Rainham
    Essex
    British18501650001
    FITZPATRICK, Dean Marvin
    26 Cranbourne Road
    N10 2BT London
    Segretario
    26 Cranbourne Road
    N10 2BT London
    British81553650001
    GRANT, Ian Gordon
    52 Gladsmuir Road
    Upper Holloway
    N19 3JU London
    Segretario
    52 Gladsmuir Road
    Upper Holloway
    N19 3JU London
    British22290880001
    SILCOX, Alex David
    136-142 Bramley Road
    London
    W10 6SR
    Segretario
    136-142 Bramley Road
    London
    W10 6SR
    175851410001
    AMEN, Patrice
    Les Amazones
    FOREIGN 31320 Anzeville
    France
    Amministratore
    Les Amazones
    FOREIGN 31320 Anzeville
    France
    French22290870001
    BAKER, Roger Christopher
    10 Devereux Drive
    WD17 3DE Watford
    Amministratore
    10 Devereux Drive
    WD17 3DE Watford
    British81553490001
    BROWN, John Dominic Weare
    120 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    Amministratore
    120 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    United KingdomBritish35549390002
    CAMPKIN, Christopher John
    86 Elthorne Park Road
    W7 2JD London
    Amministratore
    86 Elthorne Park Road
    W7 2JD London
    Great BritainBritish78308230002
    FITZPATRICK, Dean Marvin
    26 Cranbourne Road
    N10 2BT London
    Amministratore
    26 Cranbourne Road
    N10 2BT London
    EnglandBritish81553650001
    GRANT, Ian Gordon
    52 Gladsmuir Road
    Upper Holloway
    N19 3JU London
    Amministratore
    52 Gladsmuir Road
    Upper Holloway
    N19 3JU London
    EnglandBritish22290880001
    JARVIS, Andrew Calmson
    8 West Hill Court Millfield Lane
    N6 6JJ London
    Amministratore
    8 West Hill Court Millfield Lane
    N6 6JJ London
    United KingdomBritish10930910002
    JARVIS, Sara Lynn
    77 Roupell Street
    SE1 8SS London
    Amministratore
    77 Roupell Street
    SE1 8SS London
    United KingdomBritish18501680001
    KAY, Elizabeth
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    Amministratore
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    EnglandBritish176507210001
    MAZERIES, Michael
    20 Rue Saint Ursule
    FOREIGN 3100 Toulouse
    France
    Amministratore
    20 Rue Saint Ursule
    FOREIGN 3100 Toulouse
    France
    French22290850001
    ORIOL, Alain
    5 Chemin Des Sources
    FOREIGN 31120 Portet Sur Garonne
    France
    Amministratore
    5 Chemin Des Sources
    FOREIGN 31120 Portet Sur Garonne
    France
    French31584540001
    PRICE, Claire Margaret
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    Amministratore
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    England
    EnglandBritish181956820001
    PRIMROSE, Sandy Blackadder, Doctor
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Amersham Road
    HP13 6QS High Wycombe
    21
    Buckinghamshire
    EnglandBritish17972160001
    SILCOX, Alexander David
    136-142 Bramley Road
    London
    W10 6SR
    Amministratore
    136-142 Bramley Road
    London
    W10 6SR
    EnglandBritish186834220001
    SOHI, Kashmir Singh
    Bramley Road
    W10 6SR London
    136-142
    England
    Amministratore
    Bramley Road
    W10 6SR London
    136-142
    England
    EnglandBritish45116130003
    STEVENS, Geoffrey Robert
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Beech House
    3 Millhouses Court
    S11 9HZ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish57380020001

    J L DESIGN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Collateral debenture
    Creato il 12 gen 1994
    Consegnato il 14 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 14 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 dic 1993
    Consegnato il 14 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 08 dic 1992
    Consegnato il 11 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20800.34 due from the company to the chargee under the terms of an agreement
    Brevi particolari
    All the right title and interest payable under the insurances.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 11 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 ago 1989
    Consegnato il 07 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mar 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 10 mar 1989
    Consegnato il 17 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1989Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0