RENSBURG SHEPPARDS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RENSBURG SHEPPARDS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 02146011 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RENSBURG SHEPPARDS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova RENSBURG SHEPPARDS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O K & W Recovery Limited Milton Park Innovation Centre 99 Park Drive, Milton OX14 4RY Abingdon |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RENSBURG SHEPPARDS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RENSBURG SHEPPARDS PLC | 06 mag 2005 | 06 mag 2005 |
| RENSBURG PLC | 28 mag 2004 | 28 mag 2004 |
| BWD SECURITIES PLC | 19 ago 1987 | 19 ago 1987 |
| RAPID 3402 LIMITED | 08 lug 1987 | 08 lug 1987 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RENSBURG SHEPPARDS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per RENSBURG SHEPPARDS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 nov 2022 | 11 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 nov 2021 | 12 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Critchleys Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP a C/O K & W Recovery Limited Milton Park Innovation Centre 99 Park Drive, Milton Abingdon OX14 4RY in data 15 giu 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 Gresham Street London EC2V 7QN England a C/O Critchleys Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP in data 07 dic 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||||||
Notifica di Investec Group Investments (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 03 nov 2020 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||||||
Cessazione di Investec Bank Plc come persona con controllo significativo il 03 nov 2020 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale al 19 mag 2020
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Peter Wragg come amministratore in data 31 mar 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 mar 2020
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 mar 2020 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 feb 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata | 1 pagine | CERT10 | ||||||||||||||||||
Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto | 25 pagine | MAR | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata | 1 pagine | RR02 | ||||||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2019 al 30 set 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di RENSBURG SHEPPARDS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILDAY, Steven Robert | Segretario | Milton Park Innovation Centre 99 Park Drive, Milton OX14 4RY Abingdon C/O K & W Recovery Limited | 179668130001 | |||||||
| HOOLEY, Iain William | Amministratore | Milton Park Innovation Centre 99 Park Drive, Milton OX14 4RY Abingdon C/O K & W Recovery Limited | England | British | 153896520001 | |||||
| CONG, Kathy | Segretario | Gresham Street EC2V 7QP London 2 England England | 154521740001 | |||||||
| DICKINSON, Michael John | Segretario | Chiddingfold Cottage Northfield Lane Highburton HD8 0QT Huddersfield West Yorkshire | British | 8083230001 | ||||||
| HOOLEY, Iain William | Segretario | Quayside House Canal Wharf LS11 5PU Leeds | 152835320001 | |||||||
| WATTS, Paula Mary | Segretario | Canal Wharf LS11 5PU Leeds Quayside House West Yorkshire United Kingdom | British | 120535120002 | ||||||
| WRAGG, Jonathan Peter | Segretario | Whirlow Green Whirlow S11 9NY Sheffield 3 South Yorkshire | British | 66863530002 | ||||||
| ALLEN, Robert Anthony | Amministratore | Clova Mount Woodhouse Lane East Ardsley WF3 2LE Wakefield West Yorkshire | British | 10212990002 | ||||||
| ANDERSON, David | Amministratore | Reap Hirst House Reap Hirst Road HD2 2DD Huddersfield West Yorkshire | British | 47785970001 | ||||||
| ANYSZ, Barry Aubrey | Amministratore | 10 Wigton Chase Wigton Lane LS17 8SG Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 18679440001 | |||||
| BAGSHAWE, Nicholas Wilfrid | Amministratore | Toad Hall Town Row TN6 3QU Rotherfield East Sussex | England | British | 9956160002 | |||||
| BOTTOMLEY, Alan Ingham | Amministratore | Dinmore House Pateley Bridge Road, Burnt Yates HG3 3ET Harrogate North Yorkshire | British | 2670590002 | ||||||
| BROADBENT, Christopher John Bates | Amministratore | Ladyroyd Busker Lane Scissett HD8 9JU Huddersfield Yorkshire | British | 5575600001 | ||||||
| BULTEEL, David John Hillersdon | Amministratore | EC2V 7QN London 30 Gresham Street England | England | British | 75827200002 | |||||
| BURNS, Michael Hamer | Amministratore | The Rookery Hall Lane Lathom L40 5UG Ormskirk Lancashire | England | British | 43863650001 | |||||
| CLARKE, Christopher George | Amministratore | Canal Wharf LS11 5PU Leeds Quayside House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 29739960001 | |||||
| DICKINSON, Michael John | Amministratore | Chiddingfold Cottage Northfield Lane Highburton HD8 0QT Huddersfield West Yorkshire | British | 8083230001 | ||||||
| ELLIOTT, Stephen Maclaurin | Amministratore | EC2V 7QN London 30 Gresham Street England | United Kingdom | South African | 78535360001 | |||||
| ELSTONE, Henry Claude | Amministratore | Valley House Darrington WF8 3BT Pontefract West Yorkshire | United Kingdom | British | 81771100001 | |||||
| HAAN, Michael Robert Anthony | Amministratore | Canal Wharf LS11 5PU Leeds Quayside House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 141404840001 | |||||
| KANTOR, Bernard | Amministratore | EC2V 7QN London 30 Gresham Street England | England | Irish | 29467220005 | |||||
| KAYE, Simon George | Amministratore | Canal Wharf LS11 5PU Leeds Quayside House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 190800790001 | |||||
| KERR, Katrina | Amministratore | Overwood House Parkgate Road CH1 6NE Chester Cheshire | United Kingdom | British | 72284700001 | |||||
| KOSEFF, Stephen | Amministratore | EC2V 7QN London 30 Gresham Street England | South Africa | South African, | 44389980002 | |||||
| LANE FOX, George Charles Nicholas | Amministratore | Bramham Park Bramham LS23 6ND Wetherby West Yorkshire | England | English | 141284510001 | |||||
| LISTER, Robert Charles | Amministratore | Canal Wharf LS11 5PU Leeds Quayside House West Yorkshire United Kingdom | England | British | 122437000001 | |||||
| MAXWELL-SCOTT, Ian | Amministratore | Pondtail House West Hill Bank RH8 9JD Oxted Surrey | United Kingdom | British | 34876790001 | |||||
| PRICE, Judith Edna | Amministratore | EC2V 7QN London 30 Gresham Street England | England | British | 69144370001 | |||||
| SEAL, Jonathan David | Amministratore | Canal Wharf LS11 5PU Leeds Quayside House West Yorkshire United Kingdom | British | 110611550001 | ||||||
| SMITH, Isla Margaret | Amministratore | Canal Wharf LS11 5PU Leeds Quayside House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 53407330001 | |||||
| STANLEY, Peter Henry Arthur | Amministratore | Cundall Hall Cundall YO6 2RP Helperby Yorkshire | United Kingdom | British | 25918110003 | |||||
| STREET, Tomas Haydn | Amministratore | EC2V 7QN London 30 Gresham Street England | United Kingdom | British | 125502680001 | |||||
| TYRIE, Andrew Guy, The Rt Hon. The Lord Tyrie Of Chichester, | Amministratore | 9 Burton House Durniton GU28 0QU Petworth West Sussex | England | British | 84237830001 | |||||
| WELLS, Malcolm Henry Weston | Amministratore | Holmbush House Findon BN14 0SY Worthing W Sussex | British | 5373270002 | ||||||
| WILLIAMS, Nicholas Curwen | Amministratore | Thistle House Oldfield Road Heswall L60 4SN Wirral Lancashire | British | 8457900001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RENSBURG SHEPPARDS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investec Group Investments (Uk) Limited | 03 nov 2020 | Gresham Street EC2V 7QP London 30 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Investec Bank Plc | 06 apr 2016 | EC2V 7QP London 30 Gresham Street England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
RENSBURG SHEPPARDS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus letter of set-off | Creato il 12 mar 2004 Consegnato il 27 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether in sterling or any other currency. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
RENSBURG SHEPPARDS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0