CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED

CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCBS BUSINESS FURNITURE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 02146389
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 Field Court
    WC1R 5EF Gray`S Inn
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CBS BUSINESS EQUIPMENT LIMITED13 lug 198713 lug 1987

    Quali sono gli ultimi bilanci di CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    18 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Risultato della riunione dei creditori

    51 pagineAM07

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    49 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA/AM02SOC

    10 pagineAM02

    Nomina di un amministratore

    2 pagineAM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Kings Ride Court Kings Ride Ascot Berkshire SL5 7JR a 3 Field Court Gray`S Inn London WC1R 5EF in data 16 apr 2021

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 021463890015 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 021463890017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 021463890016 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 lug 2019

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Alan Stevens come amministratore in data 01 feb 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 lug 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 lug 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 dic 2015

    Stato del capitale al 22 dic 2015

    • Capitale: GBP 33,150
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 021463890016, creata il 15 mag 2015

    16 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 021463890017, creata il 15 mag 2015

    9 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREEN, Deborah Lynn
    3 Mill Green
    Binfield
    RG42 4BJ Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    3 Mill Green
    Binfield
    RG42 4BJ Bracknell
    Berkshire
    BritishSchool Administration Officer118893070001
    GREEN, Philip Norman
    Mill Green
    Binfield
    RG42 4BJ Bracknell
    3
    Berkshire
    Amministratore
    Mill Green
    Binfield
    RG42 4BJ Bracknell
    3
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director67961150001
    STEVENS, Alan Michael
    WC1R 5EF Gray`S Inn
    3 Field Court
    London
    Amministratore
    WC1R 5EF Gray`S Inn
    3 Field Court
    London
    EnglandBritishSales Director266884700001
    CAVANAGH, Damian John
    Silverley House
    40 Ravenswood Avenue
    RG45 6AY Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    Silverley House
    40 Ravenswood Avenue
    RG45 6AY Crowthorne
    Berkshire
    BritishCompany Director32946280002
    CAVANAGH, Julie Claire
    Silverley House
    40 Ravenswood Avenue
    RG45 6AY Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    Silverley House
    40 Ravenswood Avenue
    RG45 6AY Crowthorne
    Berkshire
    British78558670001
    HILL, Christopher Anthony
    Maltfield Broad Lane
    B94 5DP Tanworth In Arden
    Warwickshire
    Segretario
    Maltfield Broad Lane
    B94 5DP Tanworth In Arden
    Warwickshire
    BritishSolicitor35194420003
    STIRLING, Mark David Graham
    Scarlet Hollies
    Wokingham Road
    RG10 0RX Hurst Reading
    Berkshire
    Segretario
    Scarlet Hollies
    Wokingham Road
    RG10 0RX Hurst Reading
    Berkshire
    British18809110004
    CAVANAGH, Damian John
    Silverley House
    40 Ravenswood Avenue
    RG45 6AY Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    Silverley House
    40 Ravenswood Avenue
    RG45 6AY Crowthorne
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector32946280002
    STIRLING, Mark David Graham
    Scarlet Hollies
    Wokingham Road
    RG10 0RX Hurst Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Scarlet Hollies
    Wokingham Road
    RG10 0RX Hurst Reading
    Berkshire
    BritishDirector18809110004

    Chi sono le persone con controllo significativo di CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Philip Norman Green
    WC1R 5EF Gray`S Inn
    3 Field Court
    London
    06 apr 2016
    WC1R 5EF Gray`S Inn
    3 Field Court
    London
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2015
    Consegnato il 03 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Gable Insurance Ag
    Transazioni
    • 03 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2015
    Consegnato il 03 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Gable Insurance Ag
    Transazioni
    • 03 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2015
    Consegnato il 03 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Gable Insurance Ag
    Transazioni
    • 03 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 mar 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 apr 2007
    Consegnato il 30 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 30 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 28 giu 2005
    Consegnato il 09 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    114 kennel ride, ascot, berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 mar 1996
    Consegnato il 22 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kellock Limited
    Transazioni
    • 22 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 apr 1992
    Consegnato il 18 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kellock Limited
    Transazioni
    • 18 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 ott 1991
    Consegnato il 22 ott 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a: cbs court, 118 kennel ride, north ascot, berkshire & all interest in monies received in connection with the property. See doc for details.
    Persone aventi diritto
    • Britannia Building Society
    Transazioni
    • 22 ott 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 nov 1989
    Consegnato il 30 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the rear of 118 kennel ride, north ascot, berkshire t/n BK50391 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 nov 1989
    Consegnato il 30 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the rear of 118 kennel ride, north ascot, berkshire and proceeds of salet/n bk 208673. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 nov 1989
    Consegnato il 30 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the rear of 118 kennel ride, north ascot, berkshire t/n bk 237117 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 nov 1989
    Consegnato il 30 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the rear of 118 kennel ride, north ascot, berkshire t/n bk 238424 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 nov 1989
    Consegnato il 30 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at the rear of 118 kennel ride north ascot, berkshire t/n bk 1016 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 1989
    Consegnato il 24 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £620,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge .
    Brevi particolari
    F/H property 118 kennel ride north ascot berks t/nos : bk 208673 bk 50391 bk 237117 bk 1016 bk 238424.
    Persone aventi diritto
    • Britannia Building Society
    Transazioni
    • 24 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 24 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 apr 1988
    Consegnato il 05 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over 26 old high street, old sunningdale berkshire t/n bk 115325 and/or proceeds of sale. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 1987
    Consegnato il 25 nov 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/hold property k/as 26 high st sunningdale berkshire goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Commercial Financial Services Limited
    Transazioni
    • 25 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 24 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CBS BUSINESS FURNITURE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 apr 2022Fine dell'amministrazione
    12 apr 2021Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praticante
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    William Antony Batty
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Praticante
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0